QUALITY CARE (SE) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | QUALITY CARE (SE) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03879714 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe QUALITY CARE (SE) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de QUALITY CARE (SE) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2011 |
Quels sont les derniers dépôts pour QUALITY CARE (SE) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Angela Culhane en tant que directeur le 25 juin 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2011 | 17 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Jonathan David Calow en tant que secrétaire le 08 déc. 2011 | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Care Uk Services Ltd en tant que secrétaire le 08 déc. 2011 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 17 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Paul John Watson en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Robert Parish le 10 août 2010 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 12 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 28 pages | MG01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2009 | 17 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Deborah Jane Marriott-Boam en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Geoffrey Benn en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Douglas Umbers en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Angela Hector Culhane en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Roy Hastings en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Care Uk Services Ltd le 18 nov. 2009 | 2 pages | CH04 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Robert Parish le 16 nov. 2009 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de QUALITY CARE (SE) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Secrétaire | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | 165629830001 | |||||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||||||
| MARRIOTT-BOAM, Deborah Jane | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 151689670001 | |||||||||
| PARISH, Michael Robert | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 78828750003 | |||||||||
| WATSON, Paul John | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 82460360003 | |||||||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Secrétaire | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | 33223550003 | ||||||||||
| HUXTABLE, Lynda Janet | Secrétaire | Flint Cottage Church Street SO21 3DB Micheldever | British | 67786330002 | ||||||||||
| CARE UK SERVICES LTD | Secrétaire | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530002 | ||||||||||
| TEMPLES (NOMINEES) LIMITED | Secrétaire désigné | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004500001 | |||||||||||
| BENN, Geoffrey Richard | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 73786580001 | |||||||||
| BOOKER, Roger Ian | Administrateur | Fairview 17a Queens Road WA15 9HF Hale Cheshire | United Kingdom | British | 14044530003 | |||||||||
| CULHANE, Angela | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | England | British | 68602910001 | |||||||||
| HASTINGS, Roy | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 130098430001 | |||||||||
| HUXTABLE, Lynda Janet | Administrateur | Flint Cottage Church Street SO21 3DB Micheldever | British | 67786330002 | ||||||||||
| HUXTABLE, Roger David | Administrateur | Flint Cottage Church Street SO21 3DB Micheldever | British | 67618160002 | ||||||||||
| QUINN, David Laurence, Mr. | Administrateur | 6 Whitecross Road HP17 8BA Haddenham Buckinghamshire | England | British | 123356660001 | |||||||||
| UMBERS, Douglas | Administrateur | Connaught House The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex | United Kingdom | British | 90541690001 | |||||||||
| VOCKINS, Anthony Frederick | Administrateur | 4 Main Street Croxton Kerrial NG32 1QF Grantham The Old Post Office Lincolnshire | England | British | 130512090002 | |||||||||
| TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED | Administrateur désigné | 152 City Road EC1V 2NX London | 900004490001 |
QUALITY CARE (SE) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 21 juil. 2010 Livré le 26 juil. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 mars 2007 Livré le 04 avr. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 sept. 2006 Livré le 29 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 22 janv. 2001 Livré le 01 févr. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0