CHEMICARE HEALTH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHEMICARE HEALTH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03881748
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHEMICARE HEALTH LIMITED ?

    • Pharmacie en officine (47730) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe CHEMICARE HEALTH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHEMICARE HEALTH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour CHEMICARE HEALTH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 28 juin 2013

    • Capital: GBP 4
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2013

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael Peter Blakeman le 28 nov. 2011

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Jonathan Smith le 28 nov. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2011

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Kevin Robert Hudson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Joseph Penn en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2010

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2009

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes établis au 31 janv. 2008

    4 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2007

    21 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de CHEMICARE HEALTH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BLAKEMAN, Michael Peter
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Secrétaire
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    British126522990002
    HUDSON, Kevin Robert
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Administrateur
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    EnglandBritish69091720002
    SMITH, Paul Jonathan
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    Administrateur
    Rivington Road
    Whitehouse Industrial Estate
    WA7 3DJ Runcorn
    Cheshire
    WalesBritish63118770002
    GOULT, David Alexander
    8 Dawpool Drive
    Moreton
    CH46 0PH Wirral
    Merseyside
    Secrétaire
    8 Dawpool Drive
    Moreton
    CH46 0PH Wirral
    Merseyside
    British84910240001
    SAWBRIDGE, Gary
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    Secrétaire
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    British119400170002
    GEORGE DAVIES (NOMINEES) LIMITED
    Fountain Court
    68 Fountain Street
    M2 2FB Manchester
    Greater Manchester
    Secrétaire
    Fountain Court
    68 Fountain Street
    M2 2FB Manchester
    Greater Manchester
    67628560001
    BURROWS, Peter
    Red Rock Farmhouse
    Red Rock Lane
    WN1 2UW Haigh Wigan
    Greater Manchester
    Administrateur
    Red Rock Farmhouse
    Red Rock Lane
    WN1 2UW Haigh Wigan
    Greater Manchester
    British89658150001
    COLLINS, Mark
    125 Park Road
    Prestwich
    M25 0DU Manchester
    Administrateur
    125 Park Road
    Prestwich
    M25 0DU Manchester
    British48777060001
    MOLYNEUX, Martin
    The East Barn Arley Farm
    3 Arley Lane Haigh
    WN1 2UJ Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    The East Barn Arley Farm
    3 Arley Lane Haigh
    WN1 2UJ Wigan
    Lancashire
    British85215590001
    PENN, Joseph Jonathan
    Field House Lodge
    Mannings Lane Hoole Village
    CH2 4EU Chester
    Administrateur
    Field House Lodge
    Mannings Lane Hoole Village
    CH2 4EU Chester
    United KingdomBritish16365120018
    SAWBRIDGE, Gary
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    Administrateur
    Wood Corner
    Brookledge Road
    SK10 4JX Adlington
    Cheshire
    United KingdomBritish119400170002
    TURNER, David William
    17 Hawkridge Close
    West Houghton
    BB5 2GP Bolton
    Administrateur
    17 Hawkridge Close
    West Houghton
    BB5 2GP Bolton
    British54196220002

    CHEMICARE HEALTH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 01 août 2005
    Livré le 13 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property comprising the ground floor and basement at 6 canute place knutsford,. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mai 2005
    Livré le 16 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 6 wood street, st annes-on-sea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 16 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juil. 2004
    Livré le 07 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 hallfields road orford warrington cheshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 07 oct. 2002
    Livré le 08 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    331 norris road sale. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 2002
    Livré le 04 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    198 briercliffe road burnley. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 2001
    Livré le 05 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    104 sale road northern moor manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 nov. 2001
    Livré le 05 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    15 market street adlington chorley lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of deposit
    Créé le 01 nov. 2001
    Livré le 01 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 10509835 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 01 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2000
    Livré le 13 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a 14 elswick road preston lancashire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 mai 2000
    Livré le 17 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as land and buildings at 391 manchester road astley wigan greater manchester. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 17 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 04 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property k/a 4 and 4A parkgate lane knutsford.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2000
    Livré le 29 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 mars 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0