BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED

BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03888729
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED ?

    • (7020) /

    Où se situe BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Efm Cadogan Pier
    Cheyne Walk Chelsea
    SW3 5RQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Lee Roberts en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steven Boultbee Brooks en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven John Boultbee Brooks le 31 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven John Boultbee Brooks le 31 août 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de David Revill en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 14 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 janv. 2010

    État du capital au 28 janv. 2010

    • Capital: GBP 928,002
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Edward Revill le 28 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Steven John Boultbee Brooks le 28 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Clive Ensor Boultbee Brooks le 28 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Michael Conlon en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr David Edward Revill le 28 janv. 2010

    1 pagesCH03

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2009

    16 pagesAA

    Nomination de Mr Lee Roberts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pages225

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    17 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2007

    17 pagesAA

    legacy

    1 pages225

    Qui sont les dirigeants de BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    REVILL, David Edward
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    BritishChartered Surveyor72556720003
    BOULTBEE BROOKS, Clive Ensor
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    Herefordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    Herefordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director82993640001
    SCOTT, Keith
    4 Bakers Walk
    HP22 5YP Weston Turville
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    4 Bakers Walk
    HP22 5YP Weston Turville
    Buckinghamshire
    BritishAccountant75221310001
    WARD, Geoffrey Colin Neville
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    Secrétaire
    131 Bishopsteignton
    Shoeburyness
    SS3 8BQ Southend On Sea
    Essex
    British67300170001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BAIN, Duncan Whiteford Taylor
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    St Huberts Hill Marley Common
    GU27 3PT Haslemere
    Surrey
    BritishDirector28099480001
    BOULTBEE BROOKS, Steven John
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director67458340004
    CONLON, Michael
    384 City Road
    EC1 2QA London
    Administrateur
    384 City Road
    EC1 2QA London
    United KingdomBritishSolicitor109352660001
    CONLON, Michael
    384 City Road
    EC1 2QA London
    Administrateur
    384 City Road
    EC1 2QA London
    United KingdomBritishSolicitor109352660001
    CONLON, Michael
    384 City Road
    EC1 2QA London
    Administrateur
    384 City Road
    EC1 2QA London
    United KingdomBritishSolicitor109352660001
    GREEN, Matthew Hollister
    9015 Nw Bartholomew Drive
    Portland
    Oregon 97229
    Usa
    Administrateur
    9015 Nw Bartholomew Drive
    Portland
    Oregon 97229
    Usa
    AmericanFinance74596640001
    HANCOCK, Christopher
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    Administrateur
    Kynnersley
    Park Road Stoke Poges
    SL2 4PG Slough
    EnglandBritishDirector87069290001
    KASCH, Peter Carwile
    7 St Georges Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    7 St Georges Road
    TN13 3ND Sevenoaks
    Kent
    BritishDirector61386600002
    LEE, Charles Mackenzie
    Ongar Hill Cottage
    Magpie Lane Coleshill
    HP7 0LU Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Ongar Hill Cottage
    Magpie Lane Coleshill
    HP7 0LU Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishChartered Surveyor88355580001
    MESHIEA, Yousef Abdulaziz
    12a Ennismore Gardens
    SW7 1AA London
    Administrateur
    12a Ennismore Gardens
    SW7 1AA London
    BritishCo Director95838900001
    REVILL, David Edward
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor, Kemble House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor72556720004
    ROBERTS, David Ian
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Old Brookside House
    Winkfield Road
    SL5 7LX Ascot
    Berkshire
    BritishDirector38276960001
    ROBERTS, Lee
    Floor Kembel House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    Administrateur
    Floor Kembel House
    36-39 Broad Street
    HR4 9AR Hereford
    1st
    EnglandBritishAccountant61138670002
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector141163390001
    TRIBE, Nicholas John Grove
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Yew Tree Cottage
    Sherbourne Street, Edwardstone
    CO10 5PD Sudbury
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector141163390001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    BOURNE END (HOUNSLOW) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 15 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee or any lender on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a the trinity centre high street hounslow t/no AGL25559 by way of floating charge the undertaking which is not otherwise assigned mortgaged or charged. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Brothers International (Europe)
    Transactions
    • 15 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of assignment
    Créé le 26 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from boultbee construction limited and opalguide limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the occupational lease/s in respect of the treaty centre high street hounslow.
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) LTD (Trustee)
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of legal charge
    Créé le 26 juin 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from boultbee construction limited and opalguide limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property the treaty centre high street hounslow t/n AGL25559 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Personnes ayant droit
    • Norwich Union Mortgages (General) LTD (Trustee)
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 05 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All indebtedness,liabilities and obligations whatsoever due or to become due from any of the borrowers or any charging company to the lenders in any currency under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwde Building Society
    Transactions
    • 05 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of accession and variation to the debenture made between (1) the new charging companies (2) the initial charging companies (3) nationwide building society
    Créé le 14 juin 2001
    Livré le 21 juin 2001
    En cours
    Montant garanti
    All present and future indebtedness obligations and liabilities due from any of the borrowers and/or any charging company to the chargee under any finance document on any account whatsoever (all terms defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nationwide Building Society (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 21 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of guarantee and debenture
    Créé le 15 juin 2000
    Livré le 22 juin 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each chargor to the banks (or any of them)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders(The Security Agent)
    Transactions
    • 22 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 24 déc. 1999
    Livré le 24 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0