CORBY DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCORBY DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03891845
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CORBY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CORBY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o DELOITTE LLP
    Four
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CORBY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EMASH LIMITED10 déc. 199910 déc. 1999

    Quels sont les derniers comptes de CORBY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CORBY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Cessation de la nomination de Andrew Stephen Lake en tant que directeur le 30 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    22 pagesAM23

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    13 pagesAM16

    Avis de nomination d'un administrateur remplaçant ou supplémentaire

    3 pagesAM11

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    37 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    18 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    19 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Balbinder Singh Tattar en tant que directeur le 20 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    39 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Cessation de la nomination de James Ian Edwards en tant que directeur le 31 août 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Rockingham House Mitchell Road Corby Northamptonshire NN17 5AF à C/O Deloitte Llp Four Brindleyplace Birmingham B1 2HZ le 09 nov. 2016

    2 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 10 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 déc. 2015

    État du capital au 10 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mr Balbinder Singh Tattar en tant qu'administrateur le 25 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Ian Edwards en tant qu'administrateur le 25 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CORBY DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BEST, James Craig
    Seacroft
    99 Shore Road
    BT34 3AA Rostrevor
    County Down
    Secrétaire
    Seacroft
    99 Shore Road
    BT34 3AA Rostrevor
    County Down
    BritishCo Director29402420001
    THOMAS, Howard
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    Secrétaire désigné
    50 Iron Mill Place
    DA1 4RT Crayford
    Kent
    British900000900001
    BELL, Stephen David
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Administrateur
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritishChartered Quality Surveyor96599120002
    BEST, James Craig
    Seacroft
    99 Shore Road
    BT34 3AA Rostrevor
    County Down
    Administrateur
    Seacroft
    99 Shore Road
    BT34 3AA Rostrevor
    County Down
    United KingdomBritishCo Director29402420001
    BULLER, Alfred William
    32 Old Mill Road
    BT63 6ND Scarva
    County Down
    Administrateur
    32 Old Mill Road
    BT63 6ND Scarva
    County Down
    United KingdomBritishCompany Director78551890004
    EDWARDS, James Ian
    Ufton Fields
    Ufton
    CV33 9NX Leamington Spa
    Flax Hill
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Ufton Fields
    Ufton
    CV33 9NX Leamington Spa
    Flax Hill
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishMarketing Professional194064090001
    LAGAN, John Patrick Kevin
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Administrateur
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern IrelandBritishCompany Director35639000001
    LAKE, Andrew Stephen
    c/o Deloitte Llp
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Administrateur
    c/o Deloitte Llp
    Brindleyplace
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    EnglandBritishChartered Accountant15183270001
    LEDWIDGE, John Paul
    Greens Farm
    Norwood End Fyfield
    CM5 0RL Ongar
    Essex
    Administrateur
    Greens Farm
    Norwood End Fyfield
    CM5 0RL Ongar
    Essex
    EnglandIrishProperty Consultant57887900003
    MCCANN, Sean Gerard
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Administrateur
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    United KingdomBritishChartered Accountant145301830001
    MULLAN, Brenda
    The Studio House
    Adams Yard
    BT39 0BE Temple Patrick
    Antrim
    Northern Island
    Administrateur
    The Studio House
    Adams Yard
    BT39 0BE Temple Patrick
    Antrim
    Northern Island
    BritishCompany Director89095670001
    TATTAR, Balbinder Singh
    Penny Croft
    AL5 2PB Harpenden
    26
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Penny Croft
    AL5 2PB Harpenden
    26
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishChief Operating Officer161378770001
    TESTER, William Andrew Joseph
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    Administrateur désigné
    4 Geary House
    Georges Road
    N7 8EZ London
    United KingdomBritish900000890001

    CORBY DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 sept. 2014
    Livré le 04 oct. 2014
    En cours
    Brève description
    F/H land comprising an area of 1.40 acres or thereabouts to the south of stamford road weldon corby northamptonshire t/no NN325975.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hudson Advisors UK Limited
    Transactions
    • 04 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 nov. 2013
    Livré le 27 nov. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • South East Midlands Local Enterprise Partnership Limited
    Transactions
    • 27 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 15 nov. 2013
    Livré le 27 nov. 2013
    En cours
    Brève description
    F/H k/a land to the south and south east of gretton brook road corby northamptonshire with absolte f/h t/n NN215683 and NN211397 and the f/h land to the south side of michell road corby northamptonshire with absolute f/h t/n NN285928. L/h k/a land lying to the sout east of gretton brook road corby northamptonshire with absolte f/h t/n NN264307. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • South East Midlands Local Enterprise Partnership Limited
    Transactions
    • 27 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 juin 2013
    Livré le 06 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hudson Advisors UK Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 06 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 sept. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2013
    Livré le 03 juil. 2013
    En cours
    Brève description
    F/H l/h property k/a priors hall phases 2 and 3 priors hall corby northamptonshire t/no NN213725 NN299904 NN299905 NN304597. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Homes and Communities Agency (The Agency)
    Transactions
    • 03 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 03 mars 2010
    Livré le 15 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first legal mortgage all estates and interests in the f/h, l/h now or in the future including f/h at priors hall and stanion lane corby northamptonshire t/no.NN213725; f/h at south side of gretton brook road corby northamptonshire t/no.NN215683; f/h at west side of gretton brook road weldon northamptonshire t/no.NN212912; (for further details of properties charged please refer to form MG01) plant and machinery all computers see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 15 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Floating charge
    Créé le 03 mars 2010
    Livré le 09 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or the developer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge with full title guarantee for the payment and discharge of the secured liabilities by way of floating charge the whole of the undertaking property and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Home and Communities Agency
    Transactions
    • 09 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed charge
    Créé le 03 mars 2010
    Livré le 09 mars 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or bela partnership limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge with full title guarantee for the payment and discharge of the secured liabilities by way of second fixed charge all the right, title and interest see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Home and Communities Agency
    Transactions
    • 09 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 16 mai 2008
    Livré le 29 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of properties charged please refer to form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 29 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 21 avr. 2008
    Livré le 24 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 15 acres or thereabouts at corby northamptonshire see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 24 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental legal charge
    Créé le 06 sept. 2007
    Livré le 21 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the acquired property being land at steel road and birchington road, corby part t/no NN252842 and NN243643 together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery, all easements, rights and agreements in respect thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited (Security Trustee)
    Transactions
    • 21 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 juil. 2006
    Livré le 15 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee ("security trustee") and/or the other finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ulster Bank Limited
    Transactions
    • 15 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 sept. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 févr. 2006
    Livré le 08 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 févr. 2006
    Livré le 08 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property known as the land at priors hall and stanion lane corby t/n NN213725,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 03 févr. 2005
    Livré le 05 févr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 05 févr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 janv. 2000
    Livré le 03 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 03 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CORBY DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 oct. 2016Administration started
    11 mai 2020Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew James Cowlishaw
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    Four Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Philip Stephen Bowers
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    David Philip Soden
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0