COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED

COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMET PUMP & ENGINEERING LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03893057
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?

    • Assainissement (37000) / Approvisionnement en eau, assainissement, gestion des déchets et activités de dépollution

    Où se situe COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Private Road No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Karen Linda Pay en tant que directeur le 20 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephane Rousselot en tant qu'administrateur le 28 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Grund en tant que directeur le 11 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire le 31 mars 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 30 juil. 2014

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 janv. 2015

    État du capital au 09 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Nomination de Mrs Karen Linda Pay en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Robert Grund en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter John Lewington en tant que directeur le 27 nov. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2013

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2013

    État du capital au 16 déc. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2013 au 31 juil. 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Charles White en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hampshire GU14 8JE* le 29 août 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mr Peter John Lewington en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Melanie Linda Sowter en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROUSSELOT, Stephane
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandFrenchFinance Director202797810001
    ADAMSON, Ian
    19 Western Elms Avenue
    RG30 2AL Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    19 Western Elms Avenue
    RG30 2AL Reading
    Berkshire
    British95381580001
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    BritishDirector90062470004
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Secrétaire
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    179710940001
    WILLIAMS, Ian Andrew
    Yeoman Cottage
    41 Crowborough Lane Kents Hill
    MK7 6HE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Yeoman Cottage
    41 Crowborough Lane Kents Hill
    MK7 6HE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British105405340001
    WILLIAMS, Keith Douglas
    Silverwood London Road
    WD3 1JR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Silverwood London Road
    WD3 1JR Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director28541730002
    WILLIAMS, Lita Jane
    Silverwood
    London Road
    WD3 1JR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Silverwood
    London Road
    WD3 1JR Rickmansworth
    Hertfordshire
    British67762930001
    WILLIAMS, Sheralyn Jane
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    Secrétaire
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    British114111550001
    WHBC NOMINEE SECRETARIES LIMITED
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire désigné
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    900018580001
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector90062470004
    GRUND, Robert
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandAustrianFinance Director182385330001
    JOHN, Iain Martyn
    106 Hawley Lane
    GU14 8JE Farnborough
    Unit 1
    Hampshire
    Administrateur
    106 Hawley Lane
    GU14 8JE Farnborough
    Unit 1
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director98630830002
    LEWINGTON, Peter John
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director137420410001
    PAY, Karen Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandBritishHr Director176337440001
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Director113352030002
    WHITE, Charles Liddell
    71 The Chase
    BH31 7DE Verwood
    Dorset
    Administrateur
    71 The Chase
    BH31 7DE Verwood
    Dorset
    EnglandBritishDirector54824060001
    WILLIAMS, Keith Douglas
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    Administrateur
    231 Uxbridge Road
    WD3 8DP Rickmansworth
    Herts
    EnglandBritishCompany Director28541730003
    WILLIAMS, Lita Jane
    Silverwood
    London Road
    WD3 1JR Rickmansworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Silverwood
    London Road
    WD3 1JR Rickmansworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Director67762930001
    WHBC NOMINEE DIRECTORS LIMITED
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur désigné
    Wellesley House
    7 Clarence Parade
    GL50 3NY Cheltenham
    Gloucestershire
    900018570001

    COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A guarantee and security agreement
    Créé le 07 avr. 2009
    Livré le 17 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transactions
    • 17 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An accession deed
    Créé le 07 avr. 2009
    Livré le 16 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transactions
    • 16 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 07 avr. 2009
    Livré le 11 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2009
    • 09 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 04 janv. 2002
    Livré le 18 janv. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0