COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03893057 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?
Adresse du siège social | Private Road No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Karen Linda Pay en tant que directeur le 20 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephane Rousselot en tant qu'administrateur le 28 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Grund en tant que directeur le 11 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire le 31 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que directeur le 31 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 30 juil. 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Karen Linda Pay en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Robert Grund en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter John Lewington en tant que directeur le 27 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2013 | 18 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2013 au 31 juil. 2013 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles White en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hampshire GU14 8JE* le 29 août 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter John Lewington en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Melanie Linda Sowter en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUSSELOT, Stephane | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road | England | French | Finance Director | 202797810001 | ||||
ADAMSON, Ian | Secrétaire | 19 Western Elms Avenue RG30 2AL Reading Berkshire | British | 95381580001 | ||||||
BELL, Michael Hugh | Secrétaire | 4 Hugh De Port Lane GU51 1HT Fleet Hampshire | British | Director | 90062470004 | |||||
SOWTER, Melanie Linda | Secrétaire | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | 179710940001 | |||||||
WILLIAMS, Ian Andrew | Secrétaire | Yeoman Cottage 41 Crowborough Lane Kents Hill MK7 6HE Milton Keynes Buckinghamshire | British | 105405340001 | ||||||
WILLIAMS, Keith Douglas | Secrétaire | Silverwood London Road WD3 1JR Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 28541730002 | |||||
WILLIAMS, Lita Jane | Secrétaire | Silverwood London Road WD3 1JR Rickmansworth Hertfordshire | British | 67762930001 | ||||||
WILLIAMS, Sheralyn Jane | Secrétaire | 231 Uxbridge Road WD3 8DP Rickmansworth Herts | British | 114111550001 | ||||||
WHBC NOMINEE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | Wellesley House 7 Clarence Parade GL50 3NY Cheltenham Gloucestershire | 900018580001 | |||||||
BELL, Michael Hugh | Administrateur | 4 Hugh De Port Lane GU51 1HT Fleet Hampshire | England | British | Director | 90062470004 | ||||
GRUND, Robert | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road | England | Austrian | Finance Director | 182385330001 | ||||
JOHN, Iain Martyn | Administrateur | 106 Hawley Lane GU14 8JE Farnborough Unit 1 Hampshire | England | British | Finance Director | 98630830002 | ||||
LEWINGTON, Peter John | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | England | British | Managing Director | 137420410001 | ||||
PAY, Karen Linda | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road | England | British | Hr Director | 176337440001 | ||||
SOWTER, Melanie Linda | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | England | British | Financial Director | 113352030002 | ||||
WHITE, Charles Liddell | Administrateur | 71 The Chase BH31 7DE Verwood Dorset | England | British | Director | 54824060001 | ||||
WILLIAMS, Keith Douglas | Administrateur | 231 Uxbridge Road WD3 8DP Rickmansworth Herts | England | British | Company Director | 28541730003 | ||||
WILLIAMS, Lita Jane | Administrateur | Silverwood London Road WD3 1JR Rickmansworth Hertfordshire | British | Company Director | 67762930001 | |||||
WHBC NOMINEE DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | Wellesley House 7 Clarence Parade GL50 3NY Cheltenham Gloucestershire | 900018570001 |
COMET PUMP & ENGINEERING LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A guarantee and security agreement | Créé le 07 avr. 2009 Livré le 17 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
An accession deed | Créé le 07 avr. 2009 Livré le 16 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 avr. 2009 Livré le 11 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 04 janv. 2002 Livré le 18 janv. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0