JJTM INTERNATIONAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJJTM INTERNATIONAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03894726
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    • Autres activités des agences de placement (78109) / Activités administratives et de soutien
    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Business Innovation Centre
    Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CONCEPT GROUP INTERNATIONAL LIMITED01 mars 200501 mars 2005
    CONCEPT DESIGN AND MANUFACTURING SERVICES (GROUP HOLDINGS) LIMITED27 févr. 200127 févr. 2001
    CONCEPT DESIGN AND MANUFACTURING SERVICES LIMITED15 déc. 199915 déc. 1999

    Quels sont les derniers comptes de JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 déc. 2019

    14 pagesLIQ03

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    6 pagesLIQ10

    Changement d'adresse du siège social de 4 the Court Holywell Business Park, Northfield Road Southam CV47 0FS England à Business Innovation Centre Harry Weston Road Coventry CV3 2TX le 10 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 06 déc. 2018

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Bruno Valentine Speed en tant que directeur le 31 août 2017

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Brendan Ward 3 Hermitage Close, Lilbourne Lane Catthorpe Lutterworth LE17 6EJ England à 4 the Court Holywell Business Park, Northfield Road Southam CV47 0FS le 25 janv. 2017

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Interiors House Doyle Drive Longford Coventry West Midlands CV6 6NW à C/O Brendan Ward 3 Hermitage Close, Lilbourne Lane Catthorpe Lutterworth LE17 6EJ le 12 janv. 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination d'un secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Steve John Urry en tant que directeur le 31 déc. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Steve John Urry en tant que secrétaire le 31 déc. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 5 en partie

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WARD, Brendan Jude
    Doyle Drive
    Blackburn Road Industrial Estate
    CV6 6NW Coventry
    Interiors House
    England
    Administrateur
    Doyle Drive
    Blackburn Road Industrial Estate
    CV6 6NW Coventry
    Interiors House
    England
    EnglandBritishDirector183856330001
    ASPINALL, James Eric
    1 Hawkswood Drive
    CV7 7RD Balsall Common
    West Midlands
    Secrétaire
    1 Hawkswood Drive
    CV7 7RD Balsall Common
    West Midlands
    BritishChartered Accountant121571650001
    KNIGHT, Susan Anne
    2 Denshaw Croft
    CV2 2RB Coventry
    Warwickshire
    Secrétaire
    2 Denshaw Croft
    CV2 2RB Coventry
    Warwickshire
    BritishSales Director74379150001
    MOLLOY, Joseph John
    Hollow Farm Barn
    Ibstock Road Nailstone
    CV13 0QA Nuneaton
    Warwicks
    Secrétaire
    Hollow Farm Barn
    Ibstock Road Nailstone
    CV13 0QA Nuneaton
    Warwicks
    BritishDirector67684940002
    MURPHY, Stephen Andrew
    The Dower House
    39 Main Street Market Bosworth
    CV13 0JN Nuneaton
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Dower House
    39 Main Street Market Bosworth
    CV13 0JN Nuneaton
    Warwickshire
    BritishAccountant84782740001
    URRY, Steve John
    Interiors House Doyle Drive
    Longford
    CV6 6NW Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    Interiors House Doyle Drive
    Longford
    CV6 6NW Coventry
    West Midlands
    199017940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ASPINALL, James Eric
    1 Hawkswood Drive
    CV7 7RD Balsall Common
    West Midlands
    Administrateur
    1 Hawkswood Drive
    CV7 7RD Balsall Common
    West Midlands
    EnglandBritishChartered Accountant121571650001
    BENGER, Stephen
    Hatfield Gardens
    Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    30
    England
    Administrateur
    Hatfield Gardens
    Appleton
    WA4 5QJ Warrington
    30
    England
    EnglandBritishManagement Consultant69580100001
    BOOYSEN, Tashja
    Newbold Terrace
    CV32 4EA Leamington Spa
    Fulford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Newbold Terrace
    CV32 4EA Leamington Spa
    Fulford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector181749030001
    LEWIS, Tania
    Newbold Terrace
    CV32 4EA Leamington Spa
    Fulford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Newbold Terrace
    CV32 4EA Leamington Spa
    Fulford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    South AfricaBritishDirector182903960001
    MARTINDALE, Paul
    120 Fairisle Drive
    CV10 7LL Nuneaton
    Warwickshire
    Administrateur
    120 Fairisle Drive
    CV10 7LL Nuneaton
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector92913250001
    MOLLOY, James Thomas
    Newbold Terrace
    CV32 4EA Leamington Spa
    Fulford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Newbold Terrace
    CV32 4EA Leamington Spa
    Fulford House
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector182825960001
    MOLLOY, Joseph John
    Hollow Farm Barn
    Ibstock Road Nailstone
    CV13 0QA Nuneaton
    Warwicks
    Administrateur
    Hollow Farm Barn
    Ibstock Road Nailstone
    CV13 0QA Nuneaton
    Warwicks
    United KingdomBritishDirector67684940002
    MURPHY, Stephen Andrew
    The Dower House
    39 Main Street Market Bosworth
    CV13 0JN Nuneaton
    Warwickshire
    Administrateur
    The Dower House
    39 Main Street Market Bosworth
    CV13 0JN Nuneaton
    Warwickshire
    BritishDirector84782740001
    SPEED, Bruno Valentine
    Doyle Drive
    Blackburn Road Industrial Estate
    CV6 6NW Coventry
    Interiors House
    England
    Administrateur
    Doyle Drive
    Blackburn Road Industrial Estate
    CV6 6NW Coventry
    Interiors House
    England
    EnglandBritishManaging Director81085870002
    URRY, Steve John
    Interiors House Doyle Drive
    Longford
    CV6 6NW Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    Interiors House Doyle Drive
    Longford
    CV6 6NW Coventry
    West Midlands
    United KingdomBritishChartered Accountant199017920001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Doyle Drive
    Blackburn Road Industrial Estate
    CV6 6NW Coventry
    Interiors House
    England
    15 déc. 2016
    Doyle Drive
    Blackburn Road Industrial Estate
    CV6 6NW Coventry
    Interiors House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05211194
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    JJTM INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 23 août 2011
    Livré le 25 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 1 doyle drive coventry t/n WM733336 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ultimate Finance Limited
    Transactions
    • 25 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 03 août 2007
    Livré le 06 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ultimate Finance Limited
    Transactions
    • 06 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Second legal charge
    Créé le 12 sept. 2006
    Livré le 29 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    GBP500,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Commercial f/h premises at interiors house doyle drive longford coventry west midlands united kingdom.
    Personnes ayant droit
    • Quest for Growth Nv
    Transactions
    • 29 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Aircraft mortgage
    Créé le 11 sept. 2006
    Livré le 15 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £208,350.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    The aircraft (and all the companys right title and interest therein and any compensation rights thereto) robinson R44 ii helicopter R44 raven 11 registration marks g-funy manufacturers no 11101. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 07 mars 2006
    Livré le 14 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a interiors house, unit 1, doyle drive, longford, coventry, west midlands.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 2004
    Livré le 28 oct. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 oct. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2016Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 03 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 sept. 2003
    Livré le 03 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The amount standing to the credit of a designated deposit account from time to time pursuant to the terms of the rent deposit deed.
    Personnes ayant droit
    • W H Smith Trading Limited
    Transactions
    • 03 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 sept. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    All asset debenture
    Créé le 10 juil. 2003
    Livré le 16 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All assets of the company by way of a first fixed and floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 16 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 20 sept. 2002
    Livré le 26 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 juin 2001
    Livré le 26 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 26 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    JJTM INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 avr. 2009Date of meeting to approve CVA
    15 nov. 2011Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard James Philpott
    1 Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Leicestershire
    practitioner
    1 Waterloo Way
    LE1 6LP Leicester
    Leicestershire
    2
    DateType
    06 déc. 2018Commencement of winding up
    18 juin 2020Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Tony Mitchell
    Business Innovation Centre Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    West Midlands
    practitioner
    Business Innovation Centre Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    West Midlands
    Philip Ballard
    Business Innovation Centre Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    practitioner
    Business Innovation Centre Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0