JJTM INTERNATIONAL LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | JJTM INTERNATIONAL LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03894726 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?
Adresse du siège social | Business Innovation Centre Harry Weston Road CV3 2TX Coventry |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 05 déc. 2019 | 14 pages | LIQ03 | ||||||||||
Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal | 6 pages | LIQ10 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 4 the Court Holywell Business Park, Northfield Road Southam CV47 0FS England à Business Innovation Centre Harry Weston Road Coventry CV3 2TX le 10 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis de changement de nom" | 2 pages | CONNOT | ||||||||||
Cessation de la nomination de Bruno Valentine Speed en tant que directeur le 31 août 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Brendan Ward 3 Hermitage Close, Lilbourne Lane Catthorpe Lutterworth LE17 6EJ England à 4 the Court Holywell Business Park, Northfield Road Southam CV47 0FS le 25 janv. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Interiors House Doyle Drive Longford Coventry West Midlands CV6 6NW à C/O Brendan Ward 3 Hermitage Close, Lilbourne Lane Catthorpe Lutterworth LE17 6EJ le 12 janv. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination d'un secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steve John Urry en tant que directeur le 31 déc. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steve John Urry en tant que secrétaire le 31 déc. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 15 déc. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en partie | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 9 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 10 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WARD, Brendan Jude | Administrateur | Doyle Drive Blackburn Road Industrial Estate CV6 6NW Coventry Interiors House England | England | British | Director | 183856330001 | ||||
ASPINALL, James Eric | Secrétaire | 1 Hawkswood Drive CV7 7RD Balsall Common West Midlands | British | Chartered Accountant | 121571650001 | |||||
KNIGHT, Susan Anne | Secrétaire | 2 Denshaw Croft CV2 2RB Coventry Warwickshire | British | Sales Director | 74379150001 | |||||
MOLLOY, Joseph John | Secrétaire | Hollow Farm Barn Ibstock Road Nailstone CV13 0QA Nuneaton Warwicks | British | Director | 67684940002 | |||||
MURPHY, Stephen Andrew | Secrétaire | The Dower House 39 Main Street Market Bosworth CV13 0JN Nuneaton Warwickshire | British | Accountant | 84782740001 | |||||
URRY, Steve John | Secrétaire | Interiors House Doyle Drive Longford CV6 6NW Coventry West Midlands | 199017940001 | |||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
ASPINALL, James Eric | Administrateur | 1 Hawkswood Drive CV7 7RD Balsall Common West Midlands | England | British | Chartered Accountant | 121571650001 | ||||
BENGER, Stephen | Administrateur | Hatfield Gardens Appleton WA4 5QJ Warrington 30 England | England | British | Management Consultant | 69580100001 | ||||
BOOYSEN, Tashja | Administrateur | Newbold Terrace CV32 4EA Leamington Spa Fulford House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | South African | Director | 181749030001 | ||||
LEWIS, Tania | Administrateur | Newbold Terrace CV32 4EA Leamington Spa Fulford House Warwickshire United Kingdom | South Africa | British | Director | 182903960001 | ||||
MARTINDALE, Paul | Administrateur | 120 Fairisle Drive CV10 7LL Nuneaton Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 92913250001 | ||||
MOLLOY, James Thomas | Administrateur | Newbold Terrace CV32 4EA Leamington Spa Fulford House Warwickshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 182825960001 | ||||
MOLLOY, Joseph John | Administrateur | Hollow Farm Barn Ibstock Road Nailstone CV13 0QA Nuneaton Warwicks | United Kingdom | British | Director | 67684940002 | ||||
MURPHY, Stephen Andrew | Administrateur | The Dower House 39 Main Street Market Bosworth CV13 0JN Nuneaton Warwickshire | British | Director | 84782740001 | |||||
SPEED, Bruno Valentine | Administrateur | Doyle Drive Blackburn Road Industrial Estate CV6 6NW Coventry Interiors House England | England | British | Managing Director | 81085870002 | ||||
URRY, Steve John | Administrateur | Interiors House Doyle Drive Longford CV6 6NW Coventry West Midlands | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 199017920001 | ||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JJTM INTERNATIONAL LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concept Group Holding Ltd | 15 déc. 2016 | Doyle Drive Blackburn Road Industrial Estate CV6 6NW Coventry Interiors House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
JJTM INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 23 août 2011 Livré le 25 août 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions F/H property k/a unit 1 doyle drive coventry t/n WM733336 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 août 2007 Livré le 06 août 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Second legal charge | Créé le 12 sept. 2006 Livré le 29 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti GBP500,000 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Commercial f/h premises at interiors house doyle drive longford coventry west midlands united kingdom. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Aircraft mortgage | Créé le 11 sept. 2006 Livré le 15 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti £208,350.00 and all other monies due or to become due | |
Brèves mentions The aircraft (and all the companys right title and interest therein and any compensation rights thereto) robinson R44 ii helicopter R44 raven 11 registration marks g-funy manufacturers no 11101. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 07 mars 2006 Livré le 14 mars 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a interiors house, unit 1, doyle drive, longford, coventry, west midlands. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 oct. 2004 Livré le 28 oct. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Rent deposit deed | Créé le 01 sept. 2003 Livré le 03 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The amount standing to the credit of a designated deposit account from time to time pursuant to the terms of the rent deposit deed. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
All asset debenture | Créé le 10 juil. 2003 Livré le 16 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All assets of the company by way of a first fixed and floating charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 20 sept. 2002 Livré le 26 sept. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 15 juin 2001 Livré le 26 juin 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
JJTM INTERNATIONAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0