TOGETHER COLLECTIVE

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOGETHER COLLECTIVE
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited'
    Numéro de société 03895574
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOGETHER COLLECTIVE ?

    • Activités d'autres organisations membres n.c.a. (94990) / Autres activités de services

    Où se situe TOGETHER COLLECTIVE ?

    Adresse du siège social
    Projects The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOGETHER COLLECTIVE ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRIGHTON AND HOVE IMPETUS29 nov. 200729 nov. 2007
    BRIGHTON & HOVE COMMUNITY INITIATIVES13 déc. 199913 déc. 1999

    Quels sont les derniers comptes de TOGETHER COLLECTIVE ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2026
    Date d'échéance des prochains comptes31 déc. 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2025

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TOGETHER COLLECTIVE ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au13 déc. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation27 déc. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au13 déc. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour TOGETHER COLLECTIVE ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Nomination de Mrs Emily Daniel en tant que secrétaire le 19 déc. 2025

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de April Margaret Baker en tant que secrétaire le 19 déc. 2025

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mrs Stephanie Joy Hubbard en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher David Odedun en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025

    33 pagesAA

    Nomination de Ms Jennifer Kathryn Brooks en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Clare Helen Cole en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Anthony Charles Sutton en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Gemma Louise Baldwin en tant que directeur le 04 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ruth Bradley en tant que directeur le 04 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024

    29 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Cundy en tant que directeur le 29 nov. 2024

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Peter John Parker en tant que directeur le 11 oct. 2024

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023

    31 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Peter John Parker en tant qu'administrateur le 22 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Ms Anne Belinda Grant en tant qu'administrateur le 22 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Nomination de Vivienne Judith Benson en tant qu'administrateur le 22 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Statuts

    38 pagesMA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Gemma Louise Baldwin en tant qu'administrateur le 30 nov. 2022

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de TOGETHER COLLECTIVE ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DANIEL, Emily
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Secrétaire
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    343644590001
    BENSON, Vivienne Judith
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish306414070001
    BROOKS, Jennifer Kathryn
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish343266200001
    COLE, Clare Helen
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish343262720001
    GRANT, Anne Belinda
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish179985980004
    HUBBARD, Stephanie Joy
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish343326310001
    HYMAN, Jonathan David
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish69665410001
    NAEF, Emma-Louise
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish303013750001
    ODEDUN, Christopher David
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish343325880001
    ORRINGE, Natalie Rebecca
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    United KingdomBritish207994120001
    SUTTON, Anthony Charles
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish310734050001
    TINDAL, Alexander James
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish303013970001
    BAKER, April Margaret
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Secrétaire
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    297683890001
    CREASE, Joanna Margot
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    Secrétaire
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    170038400002
    FRANZEN, Sofie
    North Road
    BN1 1YD Brighton
    Brighthelm Centre
    England
    Secrétaire
    North Road
    BN1 1YD Brighton
    Brighthelm Centre
    England
    290621350001
    HILL, Christopher Nigel
    177 Nevill Road
    BN3 7QN Hove
    East Sussex
    Secrétaire
    177 Nevill Road
    BN3 7QN Hove
    East Sussex
    British101513700002
    HILL, Michael
    5 Selborne Place
    BN3 3EJ Hove
    E Sussex
    Secrétaire
    5 Selborne Place
    BN3 3EJ Hove
    E Sussex
    British33485290001
    LAWLESS, Steve
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    Secrétaire
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    British82551740001
    SMITH, Timothy Robin Neville
    5 Thurlow Road
    BN11 2JB Worthing
    West Sussex
    Secrétaire
    5 Thurlow Road
    BN11 2JB Worthing
    West Sussex
    British40337080001
    ANTONIO, Barrie
    83 Saunders Park View
    BN2 4EX Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    83 Saunders Park View
    BN2 4EX Brighton
    East Sussex
    British102435760001
    BALDWIN, Gemma Louise
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish303014470001
    BARTLETT, Robert Wilson
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    Administrateur
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    EnglandBritish186824280001
    BODDY, Jean Rosemary
    The Countryman Flat
    High Street
    TA24 8PS Prolock
    Somerset
    Administrateur
    The Countryman Flat
    High Street
    TA24 8PS Prolock
    Somerset
    British84615010001
    BOTIBOL, David Christopher
    20 Elizabeth Avenue
    BN3 6WG Hove
    East Sussex
    Administrateur
    20 Elizabeth Avenue
    BN3 6WG Hove
    East Sussex
    United KingdomBritish127275950001
    BOWEN, Helen Mary, Dr
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    Administrateur
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    United KingdomBritish268788110004
    BRADLEY, Ruth
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    United KingdomBritish247175390001
    BROCKEN, Cynthia
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    Administrateur
    Intergen House
    65-67 Western Road
    BN3 2JQ Hove Brigthon
    East Sussex
    Great BritainBritish101508580001
    BROWN, Nicholas John Rowley
    Hollingbury Road
    BN1 7JA Brighton
    88
    East Sussex
    Administrateur
    Hollingbury Road
    BN1 7JA Brighton
    88
    East Sussex
    EnglandBritish136870670001
    CHISNALL, Ian Peter
    85 Hollingbury Rise
    BN1 7HH Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    85 Hollingbury Rise
    BN1 7HH Brighton
    East Sussex
    United KingdomBritish72409120001
    CUNDY, David
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    EnglandBritish253334550001
    DAVIS, Elizabeth Rosina
    4 Princes Court
    Princes Avenue
    BN3 4GT Hove
    East Sussex
    Administrateur
    4 Princes Court
    Princes Avenue
    BN3 4GT Hove
    East Sussex
    British67483800001
    FLYNN, Paul
    1 Chesham Street
    BN2 1NA Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    1 Chesham Street
    BN2 1NA Brighton
    East Sussex
    British97046350001
    FRENCH, Elizabeth Alison
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    Administrateur
    The Lanes, Nile House
    Nile Street
    BN1 1HW Brighton
    Projects
    England
    United KingdomBritish166070510001
    FUREY, Edward
    70 Larkfield Way
    BN1 8EF Brighton
    East Sussex
    Administrateur
    70 Larkfield Way
    BN1 8EF Brighton
    East Sussex
    British102209460001
    FYVIE-GAULD, Marlylynn Mathieson
    Kingscote
    Laurel Drive
    RH19 3DG East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    Kingscote
    Laurel Drive
    RH19 3DG East Grinstead
    West Sussex
    British101635630002

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TOGETHER COLLECTIVE ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    13 déc. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0