TOGETHER COLLECTIVE
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TOGETHER COLLECTIVE |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
| Numéro de société | 03895574 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOGETHER COLLECTIVE ?
| Adresse du siège social | Projects The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOGETHER COLLECTIVE ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour TOGETHER COLLECTIVE ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 déc. 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 27 déc. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 13 déc. 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour TOGETHER COLLECTIVE ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomination de Mrs Emily Daniel en tant que secrétaire le 19 déc. 2025 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de April Margaret Baker en tant que secrétaire le 19 déc. 2025 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Stephanie Joy Hubbard en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher David Odedun en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2025 | 33 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Ms Jennifer Kathryn Brooks en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Clare Helen Cole en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Anthony Charles Sutton en tant qu'administrateur le 04 déc. 2025 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gemma Louise Baldwin en tant que directeur le 04 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ruth Bradley en tant que directeur le 04 déc. 2025 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2024 | 29 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Cundy en tant que directeur le 29 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Peter John Parker en tant que directeur le 11 oct. 2024 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 31 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Peter John Parker en tant qu'administrateur le 22 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Anne Belinda Grant en tant qu'administrateur le 22 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Vivienne Judith Benson en tant qu'administrateur le 22 févr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Statuts | 38 pages | MA | ||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 déc. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Gemma Louise Baldwin en tant qu'administrateur le 30 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOGETHER COLLECTIVE ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANIEL, Emily | Secrétaire | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | 343644590001 | |||||||
| BENSON, Vivienne Judith | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 306414070001 | |||||
| BROOKS, Jennifer Kathryn | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 343266200001 | |||||
| COLE, Clare Helen | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 343262720001 | |||||
| GRANT, Anne Belinda | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 179985980004 | |||||
| HUBBARD, Stephanie Joy | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 343326310001 | |||||
| HYMAN, Jonathan David | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 69665410001 | |||||
| NAEF, Emma-Louise | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 303013750001 | |||||
| ODEDUN, Christopher David | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 343325880001 | |||||
| ORRINGE, Natalie Rebecca | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | United Kingdom | British | 207994120001 | |||||
| SUTTON, Anthony Charles | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 310734050001 | |||||
| TINDAL, Alexander James | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 303013970001 | |||||
| BAKER, April Margaret | Secrétaire | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | 297683890001 | |||||||
| CREASE, Joanna Margot | Secrétaire | Intergen House 65-67 Western Road BN3 2JQ Hove Brigthon East Sussex | 170038400002 | |||||||
| FRANZEN, Sofie | Secrétaire | North Road BN1 1YD Brighton Brighthelm Centre England | 290621350001 | |||||||
| HILL, Christopher Nigel | Secrétaire | 177 Nevill Road BN3 7QN Hove East Sussex | British | 101513700002 | ||||||
| HILL, Michael | Secrétaire | 5 Selborne Place BN3 3EJ Hove E Sussex | British | 33485290001 | ||||||
| LAWLESS, Steve | Secrétaire | Intergen House 65-67 Western Road BN3 2JQ Hove Brigthon East Sussex | British | 82551740001 | ||||||
| SMITH, Timothy Robin Neville | Secrétaire | 5 Thurlow Road BN11 2JB Worthing West Sussex | British | 40337080001 | ||||||
| ANTONIO, Barrie | Administrateur | 83 Saunders Park View BN2 4EX Brighton East Sussex | British | 102435760001 | ||||||
| BALDWIN, Gemma Louise | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 303014470001 | |||||
| BARTLETT, Robert Wilson | Administrateur | Intergen House 65-67 Western Road BN3 2JQ Hove Brigthon East Sussex | England | British | 186824280001 | |||||
| BODDY, Jean Rosemary | Administrateur | The Countryman Flat High Street TA24 8PS Prolock Somerset | British | 84615010001 | ||||||
| BOTIBOL, David Christopher | Administrateur | 20 Elizabeth Avenue BN3 6WG Hove East Sussex | United Kingdom | British | 127275950001 | |||||
| BOWEN, Helen Mary, Dr | Administrateur | Intergen House 65-67 Western Road BN3 2JQ Hove Brigthon East Sussex | United Kingdom | British | 268788110004 | |||||
| BRADLEY, Ruth | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | United Kingdom | British | 247175390001 | |||||
| BROCKEN, Cynthia | Administrateur | Intergen House 65-67 Western Road BN3 2JQ Hove Brigthon East Sussex | Great Britain | British | 101508580001 | |||||
| BROWN, Nicholas John Rowley | Administrateur | Hollingbury Road BN1 7JA Brighton 88 East Sussex | England | British | 136870670001 | |||||
| CHISNALL, Ian Peter | Administrateur | 85 Hollingbury Rise BN1 7HH Brighton East Sussex | United Kingdom | British | 72409120001 | |||||
| CUNDY, David | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | England | British | 253334550001 | |||||
| DAVIS, Elizabeth Rosina | Administrateur | 4 Princes Court Princes Avenue BN3 4GT Hove East Sussex | British | 67483800001 | ||||||
| FLYNN, Paul | Administrateur | 1 Chesham Street BN2 1NA Brighton East Sussex | British | 97046350001 | ||||||
| FRENCH, Elizabeth Alison | Administrateur | The Lanes, Nile House Nile Street BN1 1HW Brighton Projects England | United Kingdom | British | 166070510001 | |||||
| FUREY, Edward | Administrateur | 70 Larkfield Way BN1 8EF Brighton East Sussex | British | 102209460001 | ||||||
| FYVIE-GAULD, Marlylynn Mathieson | Administrateur | Kingscote Laurel Drive RH19 3DG East Grinstead West Sussex | British | 101635630002 |
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour TOGETHER COLLECTIVE ?
| Notifié le | Cessé le | Déclaration |
|---|---|---|
| 13 déc. 2016 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0