PALADIN GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPALADIN GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03899759
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PALADIN GROUP LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PALADIN GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PALADIN GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TOUCHSTONE ASSET MANAGEMENT LIMITED07 avr. 200507 avr. 2005
    INVESTIGATE LIMITED17 févr. 200017 févr. 2000
    OVAL (1487) LIMITED24 déc. 199924 déc. 1999

    Quels sont les derniers comptes de PALADIN GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PALADIN GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PALADIN GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Changement d'adresse du siège social de * 305 Grays Inn Road London WC1X 8QR* le 17 avr. 2014

    1 pagesAD01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    12 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 nov. 2013

    État du capital au 27 nov. 2013

    • Capital: GBP 3,948.5
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    24 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Nomination de Christopher Martin en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr Christopher Robin Leslie Phillips en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Cowans en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter Palframan en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Roxburgh Milkins Llp en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Martin Green en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 2 Crescent Office Park Clarks Way Bath BA2 2AF* le 03 déc. 2012

    1 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 31 mars 2012

    54 pagesAA

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 20 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Annulation d'actions. État du capital au 02 sept. 2011

    • Capital: GBP 3,938.60
    8 pagesSH06

    Subdivision des actions au 22 août 2011

    9 pagesSH02

    Résolutions

    Resolutions
    44 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Sub div 22/08/2011
    RES13
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    12 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09

    Qui sont les dirigeants de PALADIN GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARTIN, Christopher
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    Secrétaire
    Gray's Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    England
    175450390001
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritish108543490005
    HUNT, Matthew William
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2 Crescent Office Park
    Administrateur
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2 Crescent Office Park
    EnglandBritish96479050001
    MIDGLEY, John Philip
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritish66732700002
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Greenfield Drive
    N2 9AF London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish46176700002
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritish47952140001
    SAUNDERS, Diana
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Secrétaire
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British68743260001
    SAUNDERS, Timothy, Mr.
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Secrétaire
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    British47952140001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Secrétaire désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Roxburgh Milkins Llp Merchants
    House North Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Secrétaire
    Roxburgh Milkins Llp Merchants
    House North Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    ALLATT, Jonathan
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    Administrateur
    33 Partition Street
    BS1 5QJ Bristol
    United KingdomBritish165674160002
    BARTON, Simon Edward
    5 Apsley Road
    Newbridge
    BA1 3LP Bath
    Avon
    Administrateur
    5 Apsley Road
    Newbridge
    BA1 3LP Bath
    Avon
    United KingdomBritish103943150001
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Administrateur
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritish76512840002
    CLARK, Jonathan
    34 Church Lane
    Wingfield
    BA14 9LW Trowbridge
    Wiltshire
    Administrateur
    34 Church Lane
    Wingfield
    BA14 9LW Trowbridge
    Wiltshire
    United KingdomBritish103943140001
    GREEN, Martin Ian
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Administrateur
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    EnglandBritish79471040002
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Administrateur
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritish87647990001
    HUNT, Matthew William
    Roseneath
    Sharpston Freshford
    BA2 7UA Bath
    Somerset
    Administrateur
    Roseneath
    Sharpston Freshford
    BA2 7UA Bath
    Somerset
    EnglandBritish96479050001
    JARRETT, Mark Stephen
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Administrateur
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritish147254950001
    PALFRAMAN, Peter
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    Administrateur
    Grays Inn Road
    WC1X 8QR London
    305
    United Kingdom
    United KingdomBritish46419220001
    TIDY, Thomas Peter
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    Administrateur
    24 Handel Mansions
    94 Wyatt Drive
    SW13 8AH London
    United KingdomBritish141619610001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Administrateur désigné
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001

    PALADIN GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 10 juin 2011
    Livré le 15 juin 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 15 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 13 févr. 2008
    Livré le 20 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 20 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over cash deposit
    Créé le 13 févr. 2008
    Livré le 15 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 04 août 2006
    Livré le 05 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured john p midgley, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683023 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 04 août 2006
    Livré le 05 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured neil g hollingworth, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number C11006687024 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 04 août 2006
    Livré le 05 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured timothy saunders, date of policy 1 august 2006, insurer/office skandia life, policy number LC1006683064 and sum assured £250,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 17 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transactions
    • 17 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over cash deposit
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 17 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all the rights title interest and benefit in the deposit and the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transactions
    • 17 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:john p midgley, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683023, sum assured:£250,000.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:timothy saunders, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:LC1006683064, sum assured:£250,000.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of life policy
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy together with the beneficial interest, name of person whose life is assured:neil g hollingworth, 27 june 2006 insurer/office:skandia life, policy no:C11006684195, sum assured (exclusive of bonuses):£250,000.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over cash deposit
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge, all the rights, title interest and benefit in the deposit and in the deposit account meaning, sort code 401413, account number 82210932. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 30 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Venture Managers Limited
    Transactions
    • 30 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 25 sept. 2001
    Livré le 06 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    750 touchstone asset management limited "a" ordinary full paid shares of £1 each and all other stocks shares bonds etc together with dividends interest or other distributions.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mai 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over shares
    Créé le 29 juin 2000
    Livré le 06 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys debts and liabilities due or to become due from the company to the chargee pursuant to the instrument
    Brèves mentions
    First fixed charge the shares and derivative assets (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jss Pinnacle Group Limited
    Transactions
    • 06 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0