35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED

35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la société35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03902892
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FORTUNEHURST LIMITED06 janv. 200006 janv. 2000

    Quels sont les derniers comptes de 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    24 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 06 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que directeur le 31 oct. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Philip John Martin en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de British Land Company Secretarial Limited en tant que secrétaire le 31 oct. 2016

    2 pagesAP04

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    3 pagesAA

    Nomination de Mr Charles John Middleton en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 janv. 2016

    État du capital au 19 janv. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 févr. 2015

    État du capital au 13 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 janv. 2014

    État du capital au 22 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Philip John Martin le 02 août 2012

    2 pagesCH01

    Nomination de Andrew David Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish146546000001
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritish79841030002
    MARTIN, Philip John
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    Runwick Hill
    Runwick Lane
    GU10 5EE Farnham
    Surrey
    British35118050001
    WILSON, Michael Anthony
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    Secrétaire
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    British68971270001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    Administrateur
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritish40766290003
    CHARLTON, Peter John
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur désigné
    17 Kirkdale Road
    AL5 2PT Harpenden
    Hertfordshire
    British900005610001
    CLUTTON, Rodney
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    Administrateur
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    British4388360001
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish73961570001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritish82020730004
    MARTIN, Philip John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish35118050001
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    Administrateur
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    British109383240001
    NETTLETON, John Dering
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    Administrateur
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    EnglandEnglish1866530002
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritish14448630001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SMITH, Andrew David
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritish108214880002
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritish106882210001
    TYLER, Michael Peters
    Haydon Park Road
    SW19 8JH London
    99
    Administrateur
    Haydon Park Road
    SW19 8JH London
    99
    British108051840001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    Administrateur
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritish73972350001
    WATES, Paul Christopher Ronald
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    EnglandBritish2119440001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur 35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Basinghall Street Unit Trust
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 janv. 2017
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiqueUnit Trust
    Autorité légaleTrusts (Jersey) Law 1984
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    35 BASINGHALL STREET SECOND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 24 mars 2005
    Livré le 07 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a basinghall house 35 basinghall street london. Its interest in all investments, all plant and machinery, all book debts and other debts, any benefit in any pension fund, its goodwill and benefit of any authorisation. Floating charge all assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Aareal Bank Ag (The Agent) as Agent and Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 07 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 05 juil. 2004
    Livré le 14 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement between each chargor (as defined) and the agent
    Créé le 02 juil. 2001
    Livré le 16 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    Freehold land k/a city point (formerly k/a britannic tower) moor lane london EC2 t/n NGL745546 for further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 16 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 18 avr. 2001
    Livré le 03 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the chargor to any finance party under each finance document to which the chargor is a party except for any obligation which if it were so included would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 24 nov. 2000
    Livré le 08 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due or to become due from wates city of london properties PLC (borrower) to the chargee under the finance documents (as defined therein)
    Brèves mentions
    The f/h property k/a basinghall house, basinghall street comprising 31-36 basinghall street, 1 & 2 basinghall avenue and guildhall chambers london t/n LN191861. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 avr. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 oct. 2000
    Livré le 25 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance party (or any of them) under each of the finance documents to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    Brèves mentions
    F/H property k/a basinghall house basinghall street comprising 31-36 basinghall street, 1 & 2 basinghall avenue and guildhall chambers london EC2 t/n LN191861. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 25 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 mars 2000
    Livré le 30 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the finance parties or any of them under each of the finance documents (all defined therein)
    Brèves mentions
    F/H property k/a basinghall house, basinghall street comprising 31-36 basinghall street, 1&2 basinghall avenue and guildhall chambers, london EC2. T/no. LN191861. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC
    Transactions
    • 30 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0