ELVET HOMES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéELVET HOMES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03917233
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ELVET HOMES LIMITED ?

    • Construction de bâtiments résidentiels (41202) / Construction
    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe ELVET HOMES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Redheugh House
    Teesdale South
    TS17 6SG Thornaby Place
    Stockton-On-Tees
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ELVET HOMES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour ELVET HOMES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    18 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 avr. 2020

    19 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Ground Floor Finchale House Belmont Business Park Durham DH1 1TW England à Redheugh House Teesdale South Thornaby Place Stockton-on-Tees TS17 6SG le 03 mai 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 avr. 2019

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    8 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 28 févr. 2019 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2018

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 28 févr. 2017

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2016

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mars 2016

    État du capital au 03 mars 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ribchesters 67 Saddler Street Durham County Durham DH1 3NP à Ground Floor Finchale House Belmont Business Park Durham DH1 1TW le 04 juin 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 mars 2015

    État du capital au 11 mars 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 mars 2014

    État du capital au 04 mars 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2013

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2012

    6 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ELVET HOMES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROONEY, Alan
    5 Millfield Road
    Whickham
    NE16 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    5 Millfield Road
    Whickham
    NE16 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishChartered Surveyor19732510001
    JOHNSON, Keith
    Leazes House
    Leazes Place
    DH1 1RE Durham
    Administrateur
    Leazes House
    Leazes Place
    DH1 1RE Durham
    EnglandBritishChartered Surveyor3947060001
    JOHNSON, Patricia
    Leazes House
    Leazes Place
    DH1 1RE Durham
    Administrateur
    Leazes House
    Leazes Place
    DH1 1RE Durham
    United KingdomBritishAdministrator Officer33274300001
    ROONEY, Alan
    5 Millfield Road
    Whickham
    NE16 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    5 Millfield Road
    Whickham
    NE16 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritishChartered Surveyor19732510001
    ROONEY, Jean Marjorie
    5 Millfield Road
    Whickham
    NE16 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    5 Millfield Road
    Whickham
    NE16 4QA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishAdministrator Officer11150110001
    MATTHEWS, David Steven
    5 York Terrace
    Coach Lane
    NE29 0EF North Shields
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    5 York Terrace
    Coach Lane
    NE29 0EF North Shields
    Tyne & Wear
    British40845530001
    CORPORATE LEGAL LIMITED
    5 York Terrace
    NE29 0EF North Shields
    Tyne & Wear
    Administrateur
    5 York Terrace
    NE29 0EF North Shields
    Tyne & Wear
    47506460001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ELVET HOMES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Keith Johnson
    Teesdale South
    TS17 6SG Thornaby Place
    Redheugh House
    Stockton-On-Tees
    06 avr. 2016
    Teesdale South
    TS17 6SG Thornaby Place
    Redheugh House
    Stockton-On-Tees
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    Mr Alan Rooney
    Teesdale South
    TS17 6SG Thornaby Place
    Redheugh House
    Stockton-On-Tees
    06 avr. 2016
    Teesdale South
    TS17 6SG Thornaby Place
    Redheugh House
    Stockton-On-Tees
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.

    ELVET HOMES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 28 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a fawdon service station, jubilee road, fawdon, newcastle. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 15 déc. 2004
    Livré le 18 déc. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H winlaton house t/nos TY411730 and TY406151. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 18 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 27 juin 2003
    Livré le 05 juil. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property the whickham social club adjoining simonside view whickham tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 30 mai 2003
    Livré le 12 juin 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a land at simonside view adjoining at whickham social club whickham tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 13 juin 2000
    Livré le 15 juin 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 15 juin 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 05 avr. 2000
    Livré le 07 avr. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)

    ELVET HOMES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 avr. 2019Commencement of winding up
    19 avr. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Adam Broadbent
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    practitioner
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link
    YO30 4XG Clifton Moor
    York
    Ian James Royle
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire
    practitioner
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    North Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0