REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED

REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03919285
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 29a Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 juin 2024
    Date d'échéance des prochains comptes31 mars 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au13 janv. 2026
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation27 janv. 2026
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au13 janv. 2025
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 13 janv. 2025 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2025 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2023

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2022

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2021

    18 pagesAA

    Modification des détails de Mr Dylan Cowen en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2021

    2 pagesPSC04

    Modification des détails de Mr Paul Gardener en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021

    2 pagesPSC04

    Notification de Harjinder Singh Rai en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2021

    2 pagesPSC01

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2020

    22 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Mr Harjinder Singh Rai en tant qu'administrateur le 01 juil. 2021

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 29B Estate Road 5 South Humberside Industrial Estate Grimsby DN31 2TG England à Unit 29a Estate Road 5 South Humberside Industrial Estate Grimsby DN31 2TG le 14 mai 2021

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Unit 2 Estate Road 6 South Humberside Industrial Estate Grimsby DN31 2TG England à Unit 29B Estate Road 5 South Humberside Industrial Estate Grimsby DN31 2TG le 14 mai 2021

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 039192850005 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de 1St Secretaries Limited en tant que secrétaire le 19 févr. 2021

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 12 janv. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de 1St Secretaries Limited en tant que secrétaire le 07 janv. 2021

    2 pagesAP04

    Deuxième dépôt pour la nomination de Mr Dylan Cowen en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Deuxième dépôt pour la nomination de Mr Paul Gardener en tant qu'administrateur

    3 pagesRP04AP01

    Qui sont les dirigeants de REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COWEN, Dylan
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    Administrateur
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    EnglandBritishDirector187467760001
    GARDENER, Paul
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    Administrateur
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    EnglandBritishDirector278178020001
    RAI, Harjinder Singh
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    Administrateur
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    EnglandBritishDirector196324430001
    HESSION, Paul Anthony
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    182687980001
    TOWNSEND, Marie
    Doebuck House
    2 Cherrytree Avenue
    LE17 4SZ Lutterworth
    Leicestershire
    Secrétaire
    Doebuck House
    2 Cherrytree Avenue
    LE17 4SZ Lutterworth
    Leicestershire
    BritishCompany Secretary68321910002
    WOODROW, Peter
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Unit 19
    Warwickshire
    Secrétaire
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Unit 19
    Warwickshire
    British153517280001
    1ST SECRETARIES LIMITED
    Shelton Street
    Covent Garden
    WC2H 9JQ London
    71-75
    England
    Secrétaire
    Shelton Street
    Covent Garden
    WC2H 9JQ London
    71-75
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement12298342
    264746250001
    ENERGIZE SECRETARY LIMITED
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    Secrétaire désigné
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    900012910001
    BARSBY, Paul Andrew
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    Administrateur
    7 Sycamore Drive
    Hollywood
    B47 5QX Birmingham
    United KingdomBritishProject Engineer68329510004
    BIGNELL, Charles Graham
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishAccountant70896750001
    BOLLE, Moritz Georg
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    Administrateur
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    GermanyGermanChief Strategy Officer251006260001
    HARRINGTON, Clive Mark
    6 Helmdon Close
    CV21 1RS Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    6 Helmdon Close
    CV21 1RS Rugby
    Warwickshire
    BritishOperations Director54930720004
    HESSION, Paul Anthony
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishAccountant161980070001
    HODGSON, Michael Brailsford
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    Administrateur
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    EnglandIrishCommercial Director226234840001
    HUNTER, John
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishChief Financial Officer205528410001
    MECH, Dennis Giovanni
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    Administrateur
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    United KingdomBritishChief Executive61240050003
    MECH, Dennis Giovanni
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishEngineer61240050003
    MERRELL, Alan Stuart
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    Administrateur
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer251466770001
    ROBSON, Thomas William
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishEngineer131424590001
    RUSHE, Brian Thomas
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    Administrateur
    Estate Road 6
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 2
    England
    EnglandBritishManagement Accountant274705980001
    SHAMUYARIRA, Reuben
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    EnglandBritishChartered Accountant193407550001
    SYMONS, David Perry
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    EnglandBritishDirector157138190001
    WATKINS, Richard Ian
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    England
    South AfricaSouth AfricanEngineer182831340001
    WHITE, David Colin
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    Administrateur
    Cottage Leap
    CV21 3XP Rugby
    Reds
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant196038030001
    WOODROW, Edward William
    5 Grange Farm Drive
    Stockton
    CV47 8FT Rugby
    Warwickshire
    Administrateur
    5 Grange Farm Drive
    Stockton
    CV47 8FT Rugby
    Warwickshire
    United KingdomBritishMarketing Director91610590002
    WOODROW, Peter
    49 Warwick Road
    CV47 0HW Southam
    Warwickshire
    Administrateur
    49 Warwick Road
    CV47 0HW Southam
    Warwickshire
    United KingdomBritishManaging Director58277910003
    ENERGIZE DIRECTOR LIMITED
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    Administrateur désigné
    31 Buxton Road
    SK2 6LS Stockport
    Cheshire
    900014010001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REACH ENGINEERING & DIVING SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Harjinder Singh Rai
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    01 juin 2021
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Paul Gardener
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    01 janv. 2021
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Dylan Cowen
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    01 janv. 2021
    Estate Road 5
    South Humberside Industrial Estate
    DN31 2TG Grimsby
    Unit 29a
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Sturrock And Robson New Energy Limited
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EG London
    4
    England
    06 déc. 2016
    Fitzhardinge Street
    W1H 6EG London
    4
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUk Company Law
    Lieu d'enregistrementCompanies House Uk
    Numéro d'enregistrement07268341
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0