VC WORLD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVC WORLD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03920909
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VC WORLD LIMITED ?

    • Activités de télécommunications filaires (61100) / Information et communication

    Où se situe VC WORLD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de VC WORLD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour VC WORLD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 sept. 2016

    11 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 07 juil. 2016

    12 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de Europe House Windmill Road Sunbury-on-Thames Middlesex TW16 7HB à 55 Baker Street London W1U 7EU le 21 juil. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 08 juil. 2015

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juil. 2014

    État du capital au 24 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital au 25 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 24/06/2014
    RES13

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Simon Porter en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Simon Porter en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Allen en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Comptes annuels établis au 04 juil. 2012

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de VC WORLD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALLEN, John
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish182527790001
    COOK, Edward Charles Peregrine Phelps
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish52906920005
    MORGAN, Anthony
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    British99904380001
    PORTER, Simon Neil
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    159312480001
    SELBY, Daniel
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    Secrétaire
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    British51588390003
    SOMERS, Harold Arnold
    57 Berrylands Road
    KT5 8PB Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    57 Berrylands Road
    KT5 8PB Surbiton
    Surrey
    British34828300001
    APEX COMPANY SERVICES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Secrétaire désigné
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004340001
    REYNOLDS PORTER CHAMBERLAIN
    Chichester House
    278-282 High Holborn
    WC1V 7HA London
    Secrétaire
    Chichester House
    278-282 High Holborn
    WC1V 7HA London
    4427140001
    CAVE, Terrence William
    32 Carroll Avenue
    BH22 8BP Ferndown
    Dorset
    Administrateur
    32 Carroll Avenue
    BH22 8BP Ferndown
    Dorset
    EnglandEnglish73014640001
    KNOX, Frederick Samuel, Mr.
    32 Fitzroy Road
    NW1 8TY London
    Administrateur
    32 Fitzroy Road
    NW1 8TY London
    United KingdomBritish125723370002
    MACFARLANE, Bruce Ferguson
    5 Inkerman Terrace
    Allen Street
    W8 6QX London
    Administrateur
    5 Inkerman Terrace
    Allen Street
    W8 6QX London
    EnglandBritish55760240001
    MACPHERSON, Alexander Blake
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish51955440001
    MORGAN, Anthony
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Smallacres
    Ditchley Road
    OX7 3QT Charlbury
    Oxfordshire
    British99904380001
    NOVELLI, George Albert
    18 Crofters Close
    GU16 6GH Deepcut
    Surrey
    Administrateur
    18 Crofters Close
    GU16 6GH Deepcut
    Surrey
    British74182160005
    PORTER, Simon Neil
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    Administrateur
    Windmill Road
    TW16 7HB Sunbury-On-Thames
    Europe House
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandUnited Kingdom55262300006
    SELBY, Daniel
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    Administrateur
    84 Temple Fortune Lane
    NW11 7TX London
    United KingdomBritish51588390003
    SOMERS, Daniel Peter
    Flat 1 129 Saint Georges Road
    SE1 6HY London
    Administrateur
    Flat 1 129 Saint Georges Road
    SE1 6HY London
    EnglandBritish67888460003
    STERE, James
    2 Chainhurst Farm Cottages
    Hunton Road
    TN12 9TA Chainhurst
    Kent
    Administrateur
    2 Chainhurst Farm Cottages
    Hunton Road
    TN12 9TA Chainhurst
    Kent
    United KingdomBritish124241250001
    WADE, Christopher John
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Lodge Place
    TW1 1RQ Twickenham
    1
    United Kingdom
    United KingdomBritish61432110001
    APEX NOMINEES LIMITED
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    Administrateur désigné
    46a Syon Lane
    TW7 5NQ Isleworth
    Middlesex
    900004330001

    VC WORLD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security accession deed
    Créé le 04 juil. 2012
    Livré le 11 juil. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor or any of them to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Indigo Capital V Sarl (The Chargee)
    Transactions
    • 11 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 avr. 2011
    Livré le 06 avr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 avr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 10 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 26 juin 2007
    Livré le 04 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 04 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 27 avr. 2007
    Livré le 03 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £15,795.00 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    Cash deposit made pursuant to the said rent deposit deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Davy Property Holdings Limited, B.J. Walsh and F.M. O'donovan T/a Owm Properties
    Transactions
    • 03 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 30 déc. 2004
    Livré le 31 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge all f/h and l/h property, all fixtures and fittings, all plant machinery and other equipment, all goodwill unpaid and/or uncalled capital, all intellectual property, all securities, all loan capital, all amounts realised and non-vesting debts. Floating charge on all other debts and the property assets and rights and on the remainder of the undertaking property rights and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 31 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 22 nov. 2004
    Livré le 25 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 44632363 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 20 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge all rights, title, interest and benefit in all sums from time to time due under all sale or supply contracts.
    Personnes ayant droit
    • Dan Somers and Graham Pay
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2003
    Livré le 14 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    VC WORLD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 juil. 2015Commencement of winding up
    26 déc. 2016Due to be dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0