DIAMOND HOMES (MK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDIAMOND HOMES (MK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03928073
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DIAMOND HOMES (MK) LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe DIAMOND HOMES (MK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    3 Carrera House
    Merlin Centre Gatehouse Close
    HP19 8DP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DIAMOND HOMES (MK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    03928073 LIMITED09 sept. 201509 sept. 2015

    Quels sont les derniers comptes de DIAMOND HOMES (MK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour DIAMOND HOMES (MK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de John Charles Saynor en tant que secrétaire le 01 févr. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 avr. 2016

    État du capital au 18 avr. 2016

    • Capital: GBP 750
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul James Sturgess le 01 janv. 2016

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2015

    5 pagesAA

    Certificat de changement de nom

    Company name changed 03928073 LIMITED\certificate issued on 04/10/15
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name04 oct. 2015

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Cessation de la nomination de James Peter Sturgess en tant que directeur le 30 avr. 2014

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Peter Sturgess en tant que directeur le 30 avr. 2014

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 sept. 2015

    État du capital au 09 sept. 2015

    • Capital: GBP 750
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2014

    5 pagesAA

    Demande de rétablissement administratif

    4 pagesRT01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed diamond homes\certificate issued on 09/09/15
    pagesCERTNM

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Nomination de Mr James Peter Sturgess en tant qu'administrateur le 01 avr. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Peter Sturgess en tant qu'administrateur le 06 mars 2014

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 févr. 2014

    État du capital au 25 févr. 2014

    • Capital: GBP 750
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 28 févr. 2013

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de , Ardenham Court Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire, HP19 8HT, United Kingdom le 06 août 2013

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 29 févr. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de DIAMOND HOMES (MK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STURGESS, Paul James
    Swinfens Yard
    Stony Stratford
    MK11 1AA Milton Keynes
    15, London House
    Bucks
    England
    Administrateur
    Swinfens Yard
    Stony Stratford
    MK11 1AA Milton Keynes
    15, London House
    Bucks
    England
    EnglandBritishProperty Consultant50448040002
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Secrétaire désigné
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    SAYNOR, John Charles
    37 The Green
    Kislingbury
    NN7 4AH Northampton
    Secrétaire
    37 The Green
    Kislingbury
    NN7 4AH Northampton
    English40717430001
    STURGESS, Allison Kathryn
    5 Home Field
    Caldecotte
    MK7 8HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    5 Home Field
    Caldecotte
    MK7 8HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    British120541030001
    STURGESS, Paul James
    4 Home Field
    Caldecotte
    MK7 8HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    4 Home Field
    Caldecotte
    MK7 8HH Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishProperty Consultant50448040001
    GOSS, David
    25 Wood End
    Little Horwood
    MK17 0PE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    25 Wood End
    Little Horwood
    MK17 0PE Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishHouse Builder20866960004
    GOSS, Robert
    6 Bernardines Way
    MK18 1BF Buckingham
    Administrateur
    6 Bernardines Way
    MK18 1BF Buckingham
    BritishHouse Builder20866950002
    HODGSON, Christopher John
    Rose Cottage
    The Ridge Bossage
    GL6 8HD Stroud
    Gloucestershire
    Administrateur
    Rose Cottage
    The Ridge Bossage
    GL6 8HD Stroud
    Gloucestershire
    EnglandBritishLand Manager87716630001
    STURGESS, James Peter
    Carrera House
    Merlin Centre Gatehouse Close
    HP19 8DP Aylesbury
    3
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Carrera House
    Merlin Centre Gatehouse Close
    HP19 8DP Aylesbury
    3
    Buckinghamshire
    EnglandBritishProperty Consultant186818420001
    STURGESS, James Peter
    Carrera House
    Merlin Centre Gatehouse Close
    HP19 8DP Aylesbury
    3
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Carrera House
    Merlin Centre Gatehouse Close
    HP19 8DP Aylesbury
    3
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSurveyor185708000001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Administrateur désigné
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    DIAMOND HOMES (MK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 02 juil. 2008
    Livré le 08 juil. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 08 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 05 sept. 2005
    Livré le 22 sept. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a land at rear of parkend hotel, parkend road, gloucester t/no GR31545. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 22 juin 2004
    Livré le 06 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at white street market lavington nr devizes wiltshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 06 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 févr. 2003
    Livré le 26 févr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings at flitton bedfordshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 déc. 2000
    Livré le 04 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property known as 98C ruskin road, northampton t/nos: NN33326, NN34598, NN163983. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 04 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 2000
    Livré le 13 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 nov. 2000
    Livré le 02 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Willen A1,milton keynes. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0