PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED

PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03929802
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Kpmg Restucturing One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BRITAX PREMIUM AIRCRAFT INTERIOR GROUP LIMITED05 janv. 200405 janv. 2004
    BRITAX AIRCRAFT INTERIOR HOLDINGS LIMITED02 nov. 200002 nov. 2000
    BRITAX AIRCRAFT INTERIOR SYSTEMS LIMITED08 mars 200008 mars 2000
    FORAY 1284 LIMITED21 févr. 200021 févr. 2000

    Quels sont les derniers comptes de PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de C/O Sof Investments Ltd 8 Hanover Street London W1S 1YQ à Kpmg Restucturing One Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham West Midlands B4 6GH le 20 févr. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 févr. 2015

    LRESSP

    Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2013

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 févr. 2014

    État du capital au 25 févr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Royal Bank of Scotland Equity Finance 12Th Floor 135 Bishopsgate London EC2M 3UR United Kingdom* le 28 janv. 2014

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Ian Mcgillivray en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Julian Asquith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Michael James Peter England en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alistair Stewart en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 21 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2012

    13 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park Chertsey Surrey KT16 0RS* le 01 août 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Maureen Hodgkinson en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    Nomination de Ian Mcgillivray en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William Devanney en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Alistair Duncan Stewart en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 déc. 2012 au 30 juin 2012

    1 pagesAA01

    État du capital au 01 mai 2012

    • Capital: GBP 6,995,487
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ASQUITH, Julian
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Restucturing
    West Midlands
    Administrateur
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Restucturing
    West Midlands
    EnglandBritishAccountant148019420001
    ENGLAND, Michael James Peter
    Bishopsgate
    12th Floor
    EC2M 3UR London
    135
    England
    Administrateur
    Bishopsgate
    12th Floor
    EC2M 3UR London
    135
    England
    United KingdomBritishAsset Manager180351910001
    CLARKE, Joanna Lindsey
    11 Northfield Road
    Harborne
    B17 0ST Birmingham
    Secrétaire désigné
    11 Northfield Road
    Harborne
    B17 0ST Birmingham
    British900019740001
    HODGKINSON, Maureen
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Secrétaire
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    British154771590001
    SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Secrétaire
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement579928
    109290008
    BETTELL, Raymond John
    Buddens Cottage
    Gaunts Common
    BH21 4JR Wimborne
    Dorset
    Administrateur
    Buddens Cottage
    Gaunts Common
    BH21 4JR Wimborne
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director29510880003
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Engineer70252730001
    CARTER, Paul Dennis
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director123148720001
    CLARKE, Joanna Lindsey
    11 Northfield Road
    Harborne
    B17 0ST Birmingham
    Administrateur désigné
    11 Northfield Road
    Harborne
    B17 0ST Birmingham
    British900019740001
    DEVANNEY, William Gerard
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    Administrateur
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director87628900001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Administrateur
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director45532880003
    FISHER, Jacqueline
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    Administrateur désigné
    926 Kingstanding Road
    B44 9NG Birmingham
    West Midlands
    British900013260001
    HARRISON, Ian
    Maes Y Gwenith
    Llanvair Discoed
    NP16 6LN Chepstow
    Monmouthshire
    Administrateur
    Maes Y Gwenith
    Llanvair Discoed
    NP16 6LN Chepstow
    Monmouthshire
    WalesBritishDirector73075390001
    HIGGINS, John Robert
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director72034840001
    JONES, Evan Taylor
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    Administrateur
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    BritishDirector40267750001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Administrateur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    LEWIS, Eric James
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director75455450001
    MADELEY, Sydney John, Dr
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    UkBritishChartered Engineer51063290002
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director34653220001
    MCCASLIN, Stuart David
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Secretary1824650002
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant148271070001
    MCGILLIVRAY, Ian
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    United KingdomBritishBank Official170383130001
    NURPURI, Jatinder Pal Singh
    5 Wallace Court
    WS6 7PG Cheslyn Hay
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Wallace Court
    WS6 7PG Cheslyn Hay
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector206372520001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Administrateur
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritishGroup Finance Director136538310002
    SELWAY, Mark Wayne
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomAustralianDirector105098120001
    STEWART, Alistair Duncan
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Royal Bank Of Scotland Equity Finance
    Floor
    135 Bishopsgate
    EC2M 3UR London
    12th
    United Kingdom
    ScotlandBritishBank Official128116940001

    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2008
    Livré le 07 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 07 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 déc. 2005
    Livré le 06 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 06 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001
    Créé le 23 août 2001
    Livré le 31 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transactions
    • 31 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 nov. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juil. 2016Dissolved on
    04 févr. 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    practitioner
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0