MISYS FINANCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMISYS FINANCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03931299
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MISYS FINANCE LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe MISYS FINANCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MISYS FINANCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALNERY NO. 1958 LIMITED22 févr. 200022 févr. 2000

    Quels sont les derniers comptes de MISYS FINANCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MISYS FINANCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 24 août 2016

    20 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 août 2015

    LRESSP

    Nomination de Mr Johannes Jacobus Olivier en tant qu'administrateur le 20 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul Woodward en tant que directeur le 20 juil. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 mars 2015

    État du capital au 02 mars 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    11 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Paul Woodward en tant qu'administrateur le 05 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sanjay Patel en tant que directeur le 28 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Van Harken en tant qu'administrateur le 31 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Mary Collins en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 févr. 2014

    État du capital au 25 févr. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2013

    12 pagesAA

    Nomination de Mrs Elizabeth Mary Collins en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Director Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanna Hawkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Sanjay Patel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Joanna Marageret Hawkes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bijal Patel en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Edward Timothy Homer le 20 mai 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de MISYS FINANCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    OLIVIER, Johannes Jacobus
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomSouth African199516920001
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    ALNERY INCORPORATIONS NO.1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Secrétaire
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    64979410001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secrétaire
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07036299
    149984630001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    Administrateur
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COOK, John
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    Administrateur
    Barnside
    GL20 7BP Tredington
    Gloucestershire
    EnglandBritish86208160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    EVANS, Howard
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Park House
    Charlton Park Gate
    GL53 7DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritish56986700002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    FULLELOVE, Glyn William
    Brook House
    Spout Lane Tansley
    DE4 5FH Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Brook House
    Spout Lane Tansley
    DE4 5FH Matlock
    Derbyshire
    United KingdomBritish73026210001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    JOHNSON, Russell Alan
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    Worcester Avenue
    Kings Hill West Malling
    ME19 4FL Kent
    14
    England
    United Kingdom
    British130788060001
    LOMAX, John Kevin
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Hawling Manor
    Hawling
    GL54 5TA Cheltenham
    Gloucestershire
    British22190280002
    MARSH, Howard Alexander David
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    Administrateur
    33 Rogers Way
    CV34 6PY Warwick
    United KingdomBritish111938620001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    Administrateur
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AB London
    Administrateur
    9 Cheapside
    EC2V 6AB London
    66825630001
    ALNERY INCORPORATIONS NO.1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Administrateur
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    64979410001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    Administrateur
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    1
    82836510002

    MISYS FINANCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 29 juil. 2003
    Livré le 12 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Créé le 23 oct. 2002
    Livré le 13 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    MISYS FINANCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    08 déc. 2017Dissolved on
    25 août 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    practitioner
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0