CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED

CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03942490
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Paragon Building
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PILOTMAXI LIMITED08 mars 200008 mars 2000

    Quels sont les derniers comptes de CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quels sont les derniers dépôts pour CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Changement d'adresse du siège social de Kingsmead Industrial Estate Princess Elizabeth Way Cheltenham Gloucestershiregl51 7Re le 03 févr. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 25 janv. 2011

    LRESSP

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 08 mars 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 mars 2010

    État du capital au 16 mars 2010

    • Capital: GBP 5,000,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher David Browning le 08 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Andrew Christopher Large le 08 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul Charles Cook le 08 mars 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Christopher David Browning le 08 mars 2010

    1 pagesCH03

    Cessation de la nomination de Nigel Thompson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    14 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    12 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    8 pages155(6)b

    legacy

    8 pages155(6)b

    legacy

    9 pages155(6)a

    legacy

    8 pages155(6)a

    Qui sont les dirigeants de CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROWNING, Christopher David
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    Secrétaire
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    BritishFinance Manager177705260001
    BROWNING, Christopher David
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    Administrateur
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    EnglandBritishFinance Director177705260001
    COOK, Paul Charles
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    Administrateur
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    EnglandBritishManaging Director23476370003
    LARGE, Andrew Christopher
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    Administrateur
    Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    The Paragon Building
    EnglandBritishManufacturing Director94105840001
    BOSKETT, Richard John
    Windrush Oakley Road
    Battledown
    GL52 6NZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Windrush Oakley Road
    Battledown
    GL52 6NZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Director23476360001
    HANNA, Roisin
    180 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    Dublin 14
    Dublin
    Ireland
    Secrétaire
    180 Holywell
    Upper Kilmacud Road
    Dublin 14
    Dublin
    Ireland
    British44105690001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLEN, Eamon Joseph
    Grenagh
    Avoca Avenue
    Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Grenagh
    Avoca Avenue
    Blackrock
    County Dublin
    Ireland
    IrishDirector33780080001
    BOSKETT, Richard John
    Windrush Oakley Road
    Battledown
    GL52 6NZ Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Windrush Oakley Road
    Battledown
    GL52 6NZ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishFinancial Director23476360001
    MCGUIRE, Vivian Francis
    Mount Crescent
    Bellevue Hill
    Delgany
    County Wicklow
    Ireland
    Administrateur
    Mount Crescent
    Bellevue Hill
    Delgany
    County Wicklow
    Ireland
    Northern IrelandIrishDirector30974070008
    THOMPSON, Nigel Maurice
    Stove House
    Fishers Place Pendock
    GL19 3PR Gloucester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Stove House
    Fishers Place Pendock
    GL19 3PR Gloucester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishSales Director67873250001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 14 déc. 2006
    Livré le 22 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 nov. 2003
    Livré le 03 déc. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Agent for Thebeneficiaries
    Transactions
    • 03 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 31 mars 2000
    Livré le 07 avr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 avr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 déc. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CHELTENHAM ARCHITECTURAL HARDWARE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    25 janv. 2011Commencement of winding up
    19 août 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Christopher Marsden
    The Paragon Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    practitioner
    The Paragon Counterslip
    BS1 6BX Bristol
    Tomislav Lukic
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham
    practitioner
    Ernst & Young
    1 Colmore Square
    B4 6HQ Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0