RHM LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRHM LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03946774
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RHM LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe RHM LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RHM LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RHM PLC01 juil. 200501 juil. 2005
    305TH SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED14 mars 200014 mars 2000

    Quels sont les derniers comptes de RHM LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au03 avr. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour RHM LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge 039467740009

    1 pagesMR05

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2022 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital au 13 déc. 2021

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 03 avr. 2021

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 01 juil. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    État du capital au 23 mars 2021

    • Capital: GBP 348,795.425
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 22/03/2021
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 22 mars 2021

    • Capital: GBP 1,801,141,827.425
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalise £515397000 and £1285396032 22/03/2021
    RES14

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 26 janv. 2021

    • Capital: GBP 348,795.425
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    État du capital après une attribution d'actions au 11 janv. 2021

    • Capital: GBP 883,900,000
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Capitalise £883.9M 11/01/2021
    RES14

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 28 mars 2020

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de RHM LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector194179970001
    ROSE, Simon Alan
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSolicitor105238100003
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Secretary125719290002
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Secrétaire
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Secrétaire
    HP9
    British145901880001
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Secrétaire
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    British42065200002
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Secrétaire désigné
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Administrateur
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    BritishFinance Director Chartered Acc73003300001
    BAULK, Michael Robert Gordon
    Cawsand Place
    West Drive Wentworth
    GU25 4NE Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Cawsand Place
    West Drive Wentworth
    GU25 4NE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishDirector13148210001
    BUCHAN, Brian John
    Manor Farmhouse
    Fyfield
    OX13 5LR Abingdon
    Oxfordshire
    Administrateur
    Manor Farmhouse
    Fyfield
    OX13 5LR Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector75146390001
    DU PLESSIS, Jan Petrus
    7 Westfield Road
    HP9 1EG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    7 Westfield Road
    HP9 1EG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishDirector31540220001
    HANSON, Richard Peter
    Low Wood House
    24 Blackhills
    KT10 9JW Esher
    Surrey
    Administrateur
    Low Wood House
    24 Blackhills
    KT10 9JW Esher
    Surrey
    BritishCompany Director42472200003
    HEPBURN, Jim
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ScotlandScottishCommercial Finance Director162125080001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector Of Companies136797430001
    LEAHY, John Joseph Mary
    Woodsgift House
    Nuffield Lane
    RG10 6QQ Wallington
    Oxfordshire
    Administrateur
    Woodsgift House
    Nuffield Lane
    RG10 6QQ Wallington
    Oxfordshire
    IrishPrincipal98660310001
    MATTHEWS, Roger John
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    Administrateur
    33 Holborn
    EC1N 2HT London
    United KingdomBritishDirector133414230001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishGeneral Counsel & Company Secretary164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishDirector168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    BritishChief Executive84644240002
    MCPHERSON, Kasey
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomNew ZealanderDirector246893430001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Administrateur
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    BritishChartered Accountant114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Controller87359710001
    SCHOEWEL, Erhard Hans Josef
    22 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    Administrateur
    22 Ashe House
    Clevedon Road
    TW1 2TT Twickenham
    Middlesex
    GermanCompany Director71409150003
    SCHOFIELD, Robert John
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    Administrateur
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritishChief Executive Officer80018490002
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Administrateur
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritishDirector42065200002
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Administrateur
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United KingdomBritishNone147725160001
    TERRY, Kenneth John
    Pear Tree House No 1 Parkgate
    SE3 9XE London
    Administrateur
    Pear Tree House No 1 Parkgate
    SE3 9XE London
    BritishCompany Director59725690001
    THOMAS, Paul
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishFinance Director29218800002
    VAZANOVA, Janka
    Flat C
    31 Palace Court
    W2 4LP London
    Administrateur
    Flat C
    31 Palace Court
    W2 4LP London
    SlovakianCompany Director71194520001
    WILKINSON, Paul Nigel
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Administrateur
    20 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    United KingdomBritishCompany Director90533810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RHM LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St. Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St. Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04426994
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    RHM LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 14 avr. 2014
    Livré le 17 avr. 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (as Agent and Trustee for the Senior Secured Creditors)
    Transactions
    • 17 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 18 août 2022L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise ne fait plus partie de la charge (MR05)
    An english law security agreement
    Créé le 30 mars 2012
    Livré le 04 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of a first floating charge all its assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 04 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A security agreement
    Créé le 27 mars 2009
    Livré le 03 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 03 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security agreement
    Créé le 12 janv. 2009
    Livré le 22 janv. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 22 janv. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Group debenture
    Créé le 28 févr. 2008
    Livré le 10 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 10 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A supplemental deed to a group debenture
    Créé le 13 avr. 2007
    Livré le 24 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 juil. 2004
    Livré le 06 août 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transactions
    • 06 août 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    First supplemental debenture to a debenture dated 21ST july 2000 between rhm group one limited, the chargors (as defined) and morgan guaranty trust company of new york as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined)
    Créé le 28 févr. 2001
    Livré le 28 févr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents (or any of them) together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection preservationor enforcement of its respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents on a full indemnity basis (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 28 févr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture between the company,rhm group two limited,rhm group three limited,rhm group four limited and rhm group a limited as chargors
    Créé le 21 juil. 2000
    Livré le 27 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the finance documents (or any of them) together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection preservation or enforcement of its respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents on a full indemnity basis (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York as Agent and Trusteefor Itself and Each of the Lenders (The "Security Agent")
    Transactions
    • 27 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0