BIOMEDIA LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBIOMEDIA LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03956152
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BIOMEDIA LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe BIOMEDIA LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o WALKER BROADBENT ASSOCIATES
    45 Boroughgate
    LS21 1AG Otley
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BIOMEDIA LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GARDINER GRAPHICS GROUP LIMITED03 janv. 200203 janv. 2002
    WINDPOWER ENGINEERS LIMITED24 mars 200024 mars 2000

    Quels sont les derniers comptes de BIOMEDIA LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BIOMEDIA LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BIOMEDIA LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 13 oct. 2015

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital11 juin 2015

    État du capital au 11 juin 2015

    • Capital: GBP 257,145
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    6 pagesAA

    Nomination de Mr Malcolm Vincent Walker en tant qu'administrateur le 01 juin 2014

    2 pagesAP01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    2 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 août 2014

    État du capital au 04 août 2014

    • Capital: GBP 257,145
    SH01

    Nomination de Walker Broadbent Associates Limited en tant qu'administrateur le 01 avr. 2014

    2 pagesAP02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Cessation de la nomination de Jane Dixon en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 avr. 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 23 avr. 2013

    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    21 pagesAA

    Période comptable précédente prolongée du 30 nov. 2011 au 31 déc. 2011

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * 1St Floor Unit 6.3 Verity Court Pochin Way Middlewich Cheshire CW10 0GW* le 09 mai 2012

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Business Direction Limited en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Salina Tomlin en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BIOMEDIA LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WALKER, Malcolm Vincent
    c/o Walker Broadbent Associates
    Boroughgate
    LS21 1AG Otley
    45
    West Yorkshire
    Administrateur
    c/o Walker Broadbent Associates
    Boroughgate
    LS21 1AG Otley
    45
    West Yorkshire
    EnglandBritishCharterd Accountant51411160001
    WALKER BROADBENT ASSOCIATES LIMITED
    Boroughgate
    Lencett House
    LS21 1AG Otley
    45
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Boroughgate
    Lencett House
    LS21 1AG Otley
    45
    West Yorkshire
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5391679
    189865000001
    BUSINESS DIRECTION LIMITED
    Sparrowgrove
    Otterbourne
    SO21 2DL Winchester
    14
    Hampshire
    Great Britain
    Secrétaire
    Sparrowgrove
    Otterbourne
    SO21 2DL Winchester
    14
    Hampshire
    Great Britain
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2428896
    69572150001
    PB SECRETARIES LIMITED
    Mount Manor House
    16 The Mount
    GU2 4HS Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    Mount Manor House
    16 The Mount
    GU2 4HS Guildford
    Surrey
    71341410001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    DIXON, Jane Louise
    Verity Court
    Pochin Way
    CW10 0GW Middlewich
    1st Floor Unit 6.3
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Verity Court
    Pochin Way
    CW10 0GW Middlewich
    1st Floor Unit 6.3
    Cheshire
    England
    EnglandBritishMarketing Director129729050001
    GARDINER, Charles
    Oakwood Farm
    Moutheys Lane Oakwood
    PO18 8AA Chichester
    West Sussex
    Administrateur
    Oakwood Farm
    Moutheys Lane Oakwood
    PO18 8AA Chichester
    West Sussex
    United KingdomBritishCompany Director37767710005
    MCPHILEMY, Anthony Peter
    292 Main Road
    PO10 8JL Southbourne
    Hampshire
    Administrateur
    292 Main Road
    PO10 8JL Southbourne
    Hampshire
    BritishProduction Director119712880001
    REES, Sean David
    357 Devizes Road
    SP2 9JN Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    357 Devizes Road
    SP2 9JN Salisbury
    Wiltshire
    BritishCompany Director71707810001
    RYAN, Adrian John
    6 Mallow Close
    PO7 8EF Waterlooville
    Hampshire
    Administrateur
    6 Mallow Close
    PO7 8EF Waterlooville
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director46877990002
    SANDERSON, Mark Angus
    10 Neville Close
    RG21 3HQ Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    10 Neville Close
    RG21 3HQ Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishSales Manager81389100001
    SANDERSON, Mark Angus
    10 Neville Close
    RG21 3HQ Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    10 Neville Close
    RG21 3HQ Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishSales Director81389100001
    TOMLIN, Salina
    Verity Court
    Pochin Way
    CW10 0GW Middlewich
    1st Floor Unit 6.3
    Cheshire
    Administrateur
    Verity Court
    Pochin Way
    CW10 0GW Middlewich
    1st Floor Unit 6.3
    Cheshire
    EnglandBritishManager173938790001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    BIOMEDIA LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 01 nov. 2010
    Livré le 05 nov. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 05 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 20 mai 2009
    Livré le 22 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Heller Limited
    Transactions
    • 22 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 14 août 2008
    Livré le 20 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited (Security Holder)
    Transactions
    • 20 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 19 juin 2006
    Livré le 01 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of $42,896 credited to account designation number 140-00-23751894 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 janv. 2006
    Livré le 18 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charles Gardiner
    Transactions
    • 18 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge of deposit
    Créé le 31 déc. 2003
    Livré le 05 janv. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation usd 140/01/23750928 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge over the book debts
    Créé le 14 janv. 2002
    Livré le 23 janv. 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    All its present and future right, title and interest in and to: a) all monies payable to the company and all other rights the company may have from time to time under a business finance agreement dated 3 january 2002 (the "business finance agreement") b) all right, title, property and interest (if any) that the company may from time to time have in and to the debts and the related rights;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nmb-Heller Limited
    Transactions
    • 23 janv. 2002Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0