BIOMEDIA LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BIOMEDIA LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03956152 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BIOMEDIA LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o WALKER BROADBENT ASSOCIATES 45 Boroughgate LS21 1AG Otley West Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BIOMEDIA LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BIOMEDIA LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour BIOMEDIA LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 13 oct. 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Malcolm Vincent Walker en tant qu'administrateur le 01 juin 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 2 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Walker Broadbent Associates Limited en tant qu'administrateur le 01 avr. 2014 | 2 pages | AP02 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jane Dixon en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 13 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 21 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 nov. 2011 au 31 déc. 2011 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 mars 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 1St Floor Unit 6.3 Verity Court Pochin Way Middlewich Cheshire CW10 0GW* le 09 mai 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Business Direction Limited en tant que secrétaire | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Salina Tomlin en tant que directeur | 2 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de BIOMEDIA LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALKER, Malcolm Vincent | Administrateur | c/o Walker Broadbent Associates Boroughgate LS21 1AG Otley 45 West Yorkshire | England | British | Charterd Accountant | 51411160001 | ||||||||
WALKER BROADBENT ASSOCIATES LIMITED | Administrateur | Boroughgate Lencett House LS21 1AG Otley 45 West Yorkshire England |
| 189865000001 | ||||||||||
BUSINESS DIRECTION LIMITED | Secrétaire | Sparrowgrove Otterbourne SO21 2DL Winchester 14 Hampshire Great Britain |
| 69572150001 | ||||||||||
PB SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Mount Manor House 16 The Mount GU2 4HS Guildford Surrey | 71341410001 | |||||||||||
TEMPLE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001120001 | |||||||||||
DIXON, Jane Louise | Administrateur | Verity Court Pochin Way CW10 0GW Middlewich 1st Floor Unit 6.3 Cheshire England | England | British | Marketing Director | 129729050001 | ||||||||
GARDINER, Charles | Administrateur | Oakwood Farm Moutheys Lane Oakwood PO18 8AA Chichester West Sussex | United Kingdom | British | Company Director | 37767710005 | ||||||||
MCPHILEMY, Anthony Peter | Administrateur | 292 Main Road PO10 8JL Southbourne Hampshire | British | Production Director | 119712880001 | |||||||||
REES, Sean David | Administrateur | 357 Devizes Road SP2 9JN Salisbury Wiltshire | British | Company Director | 71707810001 | |||||||||
RYAN, Adrian John | Administrateur | 6 Mallow Close PO7 8EF Waterlooville Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 46877990002 | ||||||||
SANDERSON, Mark Angus | Administrateur | 10 Neville Close RG21 3HQ Basingstoke Hampshire | England | British | Sales Manager | 81389100001 | ||||||||
SANDERSON, Mark Angus | Administrateur | 10 Neville Close RG21 3HQ Basingstoke Hampshire | England | British | Sales Director | 81389100001 | ||||||||
TOMLIN, Salina | Administrateur | Verity Court Pochin Way CW10 0GW Middlewich 1st Floor Unit 6.3 Cheshire | England | British | Manager | 173938790001 | ||||||||
COMPANY DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | 788-790 Finchley Road NW11 7TJ London | 900001110001 |
BIOMEDIA LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Créé le 01 nov. 2010 Livré le 05 nov. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite all assets guarantee and debenture | Cr éé le 20 mai 2009 Livré le 22 mai 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite all assets guarantee and debenture | Créé le 14 août 2008 Livré le 20 août 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 19 juin 2006 Livré le 01 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The deposit initially of $42,896 credited to account designation number 140-00-23751894 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 16 janv. 2006 Livré le 18 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge of deposit | Créé le 31 déc. 2003 Livré le 05 janv. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All deposits now and in the future credited to account designation usd 140/01/23750928 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge over the book debts | Créé le 14 janv. 2002 Livré le 23 janv. 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions All its present and future right, title and interest in and to: a) all monies payable to the company and all other rights the company may have from time to time under a business finance agreement dated 3 january 2002 (the "business finance agreement") b) all right, title, property and interest (if any) that the company may from time to time have in and to the debts and the related rights;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0