FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED

FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03957263
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED ?

    • (6110) /

    Où se situe FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3EY
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STILLWATER ENTERPRISES LIMITED27 mars 200027 mars 2000

    Quels sont les derniers comptes de FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au

    Quels sont les derniers dépôts pour FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 16 avr. 2010

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mai 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 nov. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Divers

    S/S cert. Release of liquidator
    1 pagesMISC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages287

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pages4.70

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    9 pages363s

    legacy

    2 pages88(2)R

    legacy

    1 pages123

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11

    Qui sont les dirigeants de FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VICK, Jonathan Procter
    13 Manor Park
    LA13 9UW Barrow In Furness
    Cumbria
    Secrétaire
    13 Manor Park
    LA13 9UW Barrow In Furness
    Cumbria
    British35168430002
    SERJENT, Ian Malcolm
    18 Hillfield
    Frodsham
    WA6 6DA Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    18 Hillfield
    Frodsham
    WA6 6DA Warrington
    Cheshire
    BritishDirector14137340002
    CAMMELL LAIRD GROUP PLC
    9 Bond Court
    LS1 2SW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Bond Court
    LS1 2SW Leeds
    West Yorkshire
    80907690001
    BLYTH, John Terence
    48 Wheatclose Road
    LA14 4EJ Barrow In Furness
    Cumbria
    Secrétaire
    48 Wheatclose Road
    LA14 4EJ Barrow In Furness
    Cumbria
    British807120001
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Secrétaire désigné
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    BUCHANAN, Richard Angus Fownes
    Standen Farm Smarden Road
    Biddenden
    TN27 8JT Ashford
    Kent
    Administrateur
    Standen Farm Smarden Road
    Biddenden
    TN27 8JT Ashford
    Kent
    United KingdomBritishDirector54238000003
    COBB, David Bilsland
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    Hilltop
    15 Richmondwood
    SL5 0JG Sunningdale
    Berkshire
    BritishDirector73830490002
    KELLY, Juan Herbert
    Thalloo Queen Farm
    Glen Mona
    Maughold
    Isle Of Man
    Administrateur
    Thalloo Queen Farm
    Glen Mona
    Maughold
    Isle Of Man
    BritishDirector21292930002
    STAFFORD, John Edward
    36 Paradise Lane
    Freshfield
    L37 7EJ Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    36 Paradise Lane
    Freshfield
    L37 7EJ Liverpool
    Merseyside
    BritishDirector75696590001
    OCEANIC MARINE INVESTMENTS LIMITED
    C/O Pricewaterhousecoopers
    9 Bond Court
    LS1 2SW Leeds
    Administrateur
    C/O Pricewaterhousecoopers
    9 Bond Court
    LS1 2SW Leeds
    81213450001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Administrateur désigné
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    General assignment
    Créé le 18 oct. 2002
    Livré le 22 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £350,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All company's rights,title and interest in and to the assigned property and all insurances,policies and contracts of insurance over the vessel dsv "fisher cavalier",official no 710797. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 22 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Ship mortgage
    Créé le 18 oct. 2002
    Livré le 22 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £350,000 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64 shares in the ship dsv "fisher cavalier", registered under the british flag at the port of aberdeen with official number 710797.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 22 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Ship mortgage
    Créé le 06 juin 2002
    Livré le 25 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64 shares in the ship dsv "fisher cavalier", registered in the name of the company under the british flag at the port of aberdeen with official number 710797.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 25 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Third priority mortgage of a ship
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 22 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge not exceeding us$1,000,000.00
    Brèves mentions
    64/64TH shares of the dsv "fisher cavalier",official no 710797.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 22 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General assignment
    Créé le 16 avr. 2002
    Livré le 22 avr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge not exceeding us$1,000,000.00
    Brèves mentions
    All company's rights,title and interest in and to the assigned property and all insurances,policies and contracts of insurance over the vessel dsv "fisher cavalier",official no 710797. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 22 avr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    General assignment
    Créé le 22 févr. 2002
    Livré le 02 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £1,000,000.00 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Rights title and interest, both present and future, in and to the assigned property being the insurances and requisition compensation, all of which the company has warranted under the assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 02 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second priority mortgage of a ship
    Créé le 21 févr. 2002
    Livré le 02 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £1,000,000.00 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64/64TH shares of the dsv "fisher cavalier" registered under the british flag at the port of aberdeen, with official no. 710797.
    Personnes ayant droit
    • James Fisher and Sons Public Limited Company
    Transactions
    • 02 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Tripartite agreement
    Créé le 02 nov. 2001
    Livré le 20 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An amount not exceeding £3,700,000 advanced or to be advanced to the company by the chargee pursuant to the loan agreement dated 9 march 2001 (as defined) and all other sums due or to become due from the company to the chargee pursuant to the said loan agreement, the mortgage and/or the assignment dated 9 march 2001 (as defined)
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the charter rights (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of assignment in respect of M.V. "fisher cavalier" (the vessel)
    Créé le 09 mars 2001
    Livré le 21 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An aggregate amount not exceeding £3,700,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan facility agreement dated 9 march 2001
    Brèves mentions
    All the rights, title and interest in and to the insurances the earnings and the requisition compensation (all defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An account security deed in respect of M.V. "fisher cavalier" ( the vessel)
    Créé le 09 mars 2001
    Livré le 21 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An aggregate amount not exceeding £3,700,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan facility agreement dated 9 march 2001
    Brèves mentions
    All sums standing to the credit of the earnings accounts (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of covenants collateral to a first priority british ship mortgage in respect of M.V. "fisher cavalier" (the vessel)
    Créé le 09 mars 2001
    Livré le 21 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An aggregate amount not exceeding £3,700,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan facility agreement dated 9 march 2001
    Brèves mentions
    The vessel registered in the ownership of the borrower under the flag of the united kingdom of great briatin and northern ireland at the port of aberdeen with official number 710797 together with all her engines, machinery, boats, spares, consumable and other stores. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A first priority british ship mortgage in respect of M.V. "fisher cavalier" (the vessel)
    Créé le 09 mars 2001
    Livré le 21 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    An aggregate amount not exceeding £3,700,000 and all other sums due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan facility agreement dated 9 march 2001
    Brèves mentions
    All of the vessel registered in the ownership of the borrower under the flag of the united kingdom of great britain and northern ireland at the port of averdeen with official number 710797 together with all her engines, machinery, boats, consumable and other stores. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 21 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FISHER OFFSHORE SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    26 juil. 2010Dissolved on
    05 nov. 2004Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Simon Allport
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Garry Wilson
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    Thomas Andrew Jack
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester
    practitioner
    Ernst & Young
    100 Barbirolli Square
    M2 3EY Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0