COFUNDS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COFUNDS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 03965289 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COFUNDS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Level 26 The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COFUNDS LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COFUNDS LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 20 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 06 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COFUNDS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
État du capital après une attribution d'actions au 15 déc. 2025
| 3 pages | SH01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 10 sept. 2025
| 3 pages | SH01 | ||
Cessation de la nomination de Susanna Frances Davies en tant que directeur le 30 sept. 2025 | 1 pages | TM01 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Theresa Patricia Froehlich le 25 sept. 2025 | 2 pages | CH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 juin 2025 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 20 juin 2025
| 3 pages | SH01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2024 | 27 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Alison Morris en tant que secrétaire le 19 mai 2025 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Ms Amanda Wright en tant que secrétaire le 19 mai 2025 | 2 pages | AP03 | ||
Nomination de Mr. Michele Bareggi en tant qu'administrateur le 13 mai 2025 | 2 pages | AP01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 12 mars 2025
| 3 pages | SH01 | ||
Nomination de Ms Alison Morris en tant que secrétaire le 28 déc. 2024 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de James Kenneth Mackenzie en tant que secrétaire le 28 déc. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de David Martin Dalton-Brown en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 11 déc. 2024
| 3 pages | SH01 | ||
Nomination de Mr. Nicholas Blake en tant qu'administrateur le 27 nov. 2024 | 2 pages | AP01 | ||
Démission de l'auditeur | 4 pages | AUD | ||
Cessation de la nomination de Duncan James Russell en tant que directeur le 05 nov. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||
État du capital après une attribution d'actions au 12 sept. 2024
| 3 pages | SH01 | ||
État du capital après une attribution d'actions au 20 juin 2024
| 3 pages | SH01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 06 juin 2024 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2023 | 22 pages | AA | ||
État du capital après une attribution d'actions au 14 mars 2024
| 3 pages | SH01 | ||
Cessation de la nomination de Michael John Rogers en tant que directeur le 22 janv. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Qui sont les dirigeants de COFUNDS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRIGHT, Amanda | Secrétaire | Lochside Crescent EH12 9SA Edinburgh 3 Scotland | 335989370001 | |||||||||||
| BAREGGI, Michele | Administrateur | 3 Lochside Avenue Edinburgh Park EH12 9XX Edinburgh Aegon Uk Plc Scotland | England | Italian | 214593640001 | |||||||||
| BLAKE, Nicholas, Mr. | Administrateur | Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland Scotland | United Kingdom | British | 330020520001 | |||||||||
| DAVIES, Michael Stuart | Administrateur | 1-3 Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | England | British | 291365910001 | |||||||||
| EWING, James | Administrateur | Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | United Kingdom | British | 164391750002 | |||||||||
| FROEHLICH, Theresa Patricia | Administrateur | 1-3 Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon United Kingdom | England | British | 289631470002 | |||||||||
| HESLOP, Helen Louise | Administrateur | Lochside Crescent EH12 9SE Edinburgh 1 Scotland | France | British | 240570690010 | |||||||||
| HOLLIDAY-WILLIAMS, Michael Anthony, Mr. | Administrateur | Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | United Kingdom | British | 265974660001 | |||||||||
| MCCOMB, Christina Margaret | Administrateur | 1-3 Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | England | British | 105825380004 | |||||||||
| CRAIG, Andrew John | Secrétaire | 1st Floor 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London | British | 93773780001 | ||||||||||
| MACKENZIE, James Kenneth | Secrétaire | Lochside Crescent EH12 9SE Edinburgh Aegon Uk Plc Scotland | 222226440001 | |||||||||||
| MORRIS, Alison | Secrétaire | Lochside Crescent EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | 330812720001 | |||||||||||
| PRESTON, Colin Richard | Secrétaire | The Coach House Glenbuck Road KT6 6BS Surbiton | British | 52749860002 | ||||||||||
| WELLS, Christopher Richard Parker | Secrétaire | 17 Dawnay Road Earlsfield SW18 3PQ London | New Zealander | 54463600002 | ||||||||||
| EXCELLET INVESTMENTS LIMITED | Secrétaire | Senator House 85 Queen Victoria Street EC4V 4JL London | 1872620003 | |||||||||||
| HALLMARK SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 120 East Road N1 6AA London | 900004100001 | |||||||||||
| LEGAL & GENERAL CO SEC LIMITED | Secrétaire | Coleman Street EC2R 5AA London One England |
| 147653290001 | ||||||||||
| AINSWORTH, Alan John, Dr | Administrateur | 15 Greenwood Way TN13 2LA Sevenoaks Kent | British | 17989170005 | ||||||||||
| AINSWORTH, Alan John, Dr | Administrateur | The Glenn Pennington Road TN4 0SX Tunbridge Wells Kent | British | 17989170002 | ||||||||||
| AKERS, Ann | Administrateur | Nelson Farm Giles Lane Landford SP5 2BG Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 115210180001 | |||||||||
| ALDRIDGE, Rodney Paul | Administrateur | September Ridgeway Hutton Mount CM13 2LP Brentwood Essex | British | 79418520003 | ||||||||||
| BLOOM, Mark | Administrateur | Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | America | American | 222267320001 | |||||||||
| BOOTHMAN, Clive Nicholas | Administrateur | 331 Riverside West Smugglers Way SW18 1ED London | England | British | 101848290001 | |||||||||
| BULSTRODE, Marc Robert Andrew | Administrateur | Mayland Road Witham CM8 2UX Essex Cofunds House United Kingdom | United Kingdom | British | 207033100001 | |||||||||
| BURY, James Michael | Administrateur | EC2R 5AA London One Coleman Street United Kingdom | United Kingdom | British | 89914600003 | |||||||||
| CAREY, Jonathan Hugh David | Administrateur | Weston Farmhouse Weston GU32 3NN Petersfield Hampshire | England | British | 40325440002 | |||||||||
| CHALLENOR, Thomas William | Administrateur | 1st Floor 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London | England | British | 54906450002 | |||||||||
| COCKBURN, Karen Josephine | Administrateur | Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | Scotland | British | 222240300001 | |||||||||
| CONWAY, Alastair | Administrateur | 1st Floor 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London | England | British | 37933490012 | |||||||||
| CREAK, Andrew Robert | Administrateur | 61 Little Baddow Road CM3 4NT Danbury Essex | United Kingdom | British | 147931970001 | |||||||||
| DALTON-BROWN, David Martin | Administrateur | Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon Scotland | England | British | 222150010002 | |||||||||
| DAVIES, Susanna Frances | Administrateur | 1-3 Lochside Crescent Edinburgh Park EH12 9SE Edinburgh Aegon United Kingdom | England | British | 142350460001 | |||||||||
| DAVIS, Martin Michael Arthur | Administrateur | 1st Floor 1 Minster Court Mincing Lane EC3R 7AA London | United Kingdom | British | 163262760001 | |||||||||
| DYER, Stuart Charles Elliott | Administrateur | 226 Ben Jonson House Barbican EC2Y 8DL London | England | British | 51332110002 | |||||||||
| EASTWOOD, Adrian Mark | Administrateur | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London Level 26 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 157241990001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COFUNDS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Uk Investment Holdings Limited | 05 mars 2021 | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London Level 26 United Kingdom United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Aegon Uk Plc | 01 janv. 2017 | The Leadenhall Building 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London Level 26 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Cofunds Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Coleman Street EC2R 5AA London One United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0