TANGRAM LEISURE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTANGRAM LEISURE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03966166
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TANGRAM LEISURE LIMITED ?

    • (9304) /

    Où se situe TANGRAM LEISURE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TANGRAM LEISURE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour TANGRAM LEISURE LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour TANGRAM LEISURE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    4 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 mai 2013

    18 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 02 mai 2013

    26 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 mars 2013

    14 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 sept. 2012

    13 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Cessation de la nomination de Stephen John Thursfield Brown en tant que directeur le 25 juin 2012

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Martin Tory en tant que directeur le 25 juin 2012

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Ricard Cronk en tant que directeur le 25 juin 2012

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Angela Horsman en tant que directeur le 25 juin 2012

    2 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 06 mai 2012

    14 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    9 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    10 pages2.17B

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Changement d'adresse du siège social de 16a Forest Gate Pewsey Chippenham Wiltshire SN15 3RS le 10 nov. 2011

    2 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Russell Charles Pope en tant que directeur le 29 sept. 2011

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    15 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 août 2011

    État du capital au 03 août 2011

    • Capital: GBP 861,569.5
    SH01

    Cessation de la nomination de Antonia Hawkins en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Peter Martin Tory le 01 janv. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    19 pagesAA

    Nomination de Ms Antonia Bernadette Hawkins en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2010. La liste des actionnaires a été modifiée

    15 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de TANGRAM LEISURE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TORY, Peter Martin
    48 Crown Road
    SL7 2QG Marlow
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    48 Crown Road
    SL7 2QG Marlow
    Buckinghamshire
    BritishAccountant61515010001
    WILLIAMS, Tanya Jane
    73 Rowden Hill
    SN15 2AL Chippenham
    Wiltshire
    Secrétaire
    73 Rowden Hill
    SN15 2AL Chippenham
    Wiltshire
    British66445890001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    BROWN, Stephen John Thursfield
    73 Exeter Gardens
    PE9 2SA Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    73 Exeter Gardens
    PE9 2SA Stamford
    Lincolnshire
    EnglandBritishDirector17541670001
    CRONK, Paul Ricard
    Millies House
    Neston
    SN13 9SZ Corsham
    Wiltshire
    Administrateur
    Millies House
    Neston
    SN13 9SZ Corsham
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director26743280001
    HAWKINS, Antonia Bernadette
    Frinton Road
    CO16 0JD Thorpe Le Soken
    Lifehouse Tangram Leisure Ltd
    Essex
    Administrateur
    Frinton Road
    CO16 0JD Thorpe Le Soken
    Lifehouse Tangram Leisure Ltd
    Essex
    United KingdomBritishNone125180760001
    HORSMAN, Angela
    Church Lane
    CT4 7AF Canterbury
    Nackington Farmhouse
    Kent
    Administrateur
    Church Lane
    CT4 7AF Canterbury
    Nackington Farmhouse
    Kent
    EnglandBritishNone125119110001
    POPE, Russell Charles
    Albemarle Street
    W1S 4HH London
    10
    Administrateur
    Albemarle Street
    W1S 4HH London
    10
    EnglandBritishNone126200290001
    TORY, Peter Martin
    48 Crown Road
    SL7 2QG Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    48 Crown Road
    SL7 2QG Marlow
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishAccountant61515010001
    WOOTTON, Martin John
    Lakeside Cottage
    Thorpe Hall Station Road
    CO16 0HN Thorpe Le Soken
    Essex
    Administrateur
    Lakeside Cottage
    Thorpe Hall Station Road
    CO16 0HN Thorpe Le Soken
    Essex
    United KingdomBritishHotelier38289740002
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    TANGRAM LEISURE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed charge
    Créé le 24 mai 2010
    Livré le 27 mai 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its rights title and interest in the monies standing in credit in a blocked account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mr Paul Cronk
    Transactions
    • 27 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed in respect of building contract
    Créé le 08 sept. 2009
    Livré le 12 sept. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The building contract dated 24 march 2009 and made between the company and hutton construction limited.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 mars 2008
    Livré le 27 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hotbed Limited as Security Trustee for the Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 27 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 19 sept. 2007
    Livré le 21 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 19 sept. 2007
    Livré le 21 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a thorpe hall thorpe le soken essex t/no's EX654059,EX658137,EX697568,EX683434 the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 21 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 17 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land adjoining frinton road thorpe le soken t/n EX697568 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 05 sept. 2003
    Livré le 17 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Land adjoining frinton road thorpe le soken t/n EX697568 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 déc. 2002
    Livré le 17 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property known as thorpe hall station road thorpe-le-soken essex t/n's EX658137, EX654059 & EX683434.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 juin 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 juin 2002
    Livré le 22 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Thorpe hall station road thorpe-le-soken essex t/n EX654059, land to the east of station road thorpe-le-soken essex t/n EX658137.
    Personnes ayant droit
    • Paule Owen Max Owen Michael Hollington Paul Cronk Christopher Thrift Matthew Thorn
    Transactions
    • 22 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge of whole
    Créé le 10 nov. 2000
    Livré le 15 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £1,000,000 and all other monies from the company to the chargee under the terms of the deed
    Brèves mentions
    The cottage at thorpe hall and surrounding land at thorpe le soken essex t/no;-EX539891 (part).
    Personnes ayant droit
    • Drury Investments Limited
    Transactions
    • 15 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TANGRAM LEISURE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    02 mai 2013Administration ended
    07 nov. 2011Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David Robert Thurgood
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    James Henry Stewart-Koster
    30 Finsbury Square
    London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0