GRO-GROUP UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GRO-GROUP UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03966925 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GRO-GROUP UK LIMITED ?
Adresse du siège social | Mayborn House Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GRO-GROUP UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour GRO-GROUP UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 6 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Northumberland Northumberland Business Park West Cramlington Northumberland NE23 7RH England à Mayborn House Balliol Business Park Newcastle upon Tyne NE12 8EW le 28 sept. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 29 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR à Northumberland Northumberland Business Park West Cramlington Northumberland NE23 7RH le 20 déc. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Gough en tant que directeur le 19 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen William Parkin en tant qu'administrateur le 19 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David John Gough en tant que secrétaire le 19 déc. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michelmores Secretaries Limited en tant que secrétaire le 19 déc. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr James William Matthew Taylor en tant qu'administrateur le 19 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John Gough le 01 août 2013 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 6 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Taylor Jones en tant que directeur le 16 août 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2015 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GRO-GROUP UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARKIN, Stephen William | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 115333810003 | ||||||||
TAYLOR, James William Matthew | Administrateur | Balliol Business Park NE12 8EW Newcastle Upon Tyne Mayborn House United Kingdom | England | British | Director | 220648350001 | ||||||||
BREWER, Suzanne | Secrétaire désigné | Somerset House 40-49 Price Street B2 5DN Birmingham | British | 900004890001 | ||||||||||
GOUGH, David John | Secrétaire | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House Devon United Kingdom | 159716370001 | |||||||||||
HOLMES, Ouvrielle | Secrétaire | The Old Rectory Aveton Gifford TQ7 4LG Kingsbridge Devon | British | Company Secretary | 69442890001 | |||||||||
WILLIAMS, Jennifer Christine | Secrétaire | Linhay Business Park Ashburton TQ13 7UP Devon | British | Director | 75705680001 | |||||||||
MICHELMORES SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House Devon United Kingdom |
| 107218000001 | ||||||||||
BREWER, Kevin, Dr | Administrateur désigné | Somerset House 40-49 Price Street B4 6LZ Birmingham | England | British | 900004880001 | |||||||||
DENNING, Edward Timothy | Administrateur | South Knighton House South Knighton TQ12 6NP Newton Abbot Devon | British | Director | 104305230001 | |||||||||
GOUGH, David John | Administrateur | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House Devon United Kingdom | England | British | Finance Director | 134326940002 | ||||||||
HOLMES, Ouvrielle | Administrateur | Linhay Business Park Ashburton TQ13 7UP Devon | United Kingdom | British | Company Director | 69442890001 | ||||||||
HOLMES, Robert Douglas | Administrateur | Linhay Business Park Ashburton TQ13 7UP Devon | Uk | British | Company Director | 69442940001 | ||||||||
JONES, Christian Taylor | Administrateur | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House Devon United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 174405210001 | ||||||||
WESTERMAN, Laetitia | Administrateur | 1 Davis Cottages Butterleigh EX15 1PN Cullompton Devon | French | Director | 112343450001 | |||||||||
WILLIAMS, Jennifer Christine | Administrateur | Linhay Business Park Ashburton TQ13 7UP Devon | England | British | Director | 75705680001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GRO-GROUP UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gro-Group Limited | 06 avr. 2016 | Pynes Hill EX2 5WR Exeter Woodwater House Devon United Kingdom | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
GRO-GROUP UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 03 mai 2013 Livré le 07 mai 2013 | En cours | ||
Brève description N/A. notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Loan note instrument | Créé le 14 mars 2013 Livré le 21 mars 2013 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due by any or all of the obligors to the stockholders and/or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee and debenture | Créé le 14 mars 2013 Livré le 19 mars 2013 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from michco 1209 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Créé le 01 août 2005 Livré le 02 août 2005 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 27 août 2003 Livré le 28 août 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 05 janv. 2001 Livré le 17 janv. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0