GRO-GROUP UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGRO-GROUP UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03966925
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GRO-GROUP UK LIMITED ?

    • Commerce de gros de biens ménagers (autres que les instruments de musique) n.c.a. (46499) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe GRO-GROUP UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mayborn House
    Balliol Business Park
    NE12 8EW Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GRO-GROUP UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GROBAG LIMITED06 avr. 200006 avr. 2000

    Quels sont les derniers comptes de GRO-GROUP UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour GRO-GROUP UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    6 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Northumberland Northumberland Business Park West Cramlington Northumberland NE23 7RH England à Mayborn House Balliol Business Park Newcastle upon Tyne NE12 8EW le 28 sept. 2018

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 30 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    29 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Changement d'adresse du siège social de Woodwater House Pynes Hill Exeter Devon EX2 5WR à Northumberland Northumberland Business Park West Cramlington Northumberland NE23 7RH le 20 déc. 2017

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de David John Gough en tant que directeur le 19 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen William Parkin en tant qu'administrateur le 19 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David John Gough en tant que secrétaire le 19 déc. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Michelmores Secretaries Limited en tant que secrétaire le 19 déc. 2017

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr James William Matthew Taylor en tant qu'administrateur le 19 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David John Gough le 01 août 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christian Taylor Jones en tant que directeur le 16 août 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 avr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 mai 2016

    État du capital au 03 mai 2016

    • Capital: GBP 900
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2015 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GRO-GROUP UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PARKIN, Stephen William
    Balliol Business Park
    NE12 8EW Newcastle Upon Tyne
    Mayborn House
    United Kingdom
    Administrateur
    Balliol Business Park
    NE12 8EW Newcastle Upon Tyne
    Mayborn House
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector115333810003
    TAYLOR, James William Matthew
    Balliol Business Park
    NE12 8EW Newcastle Upon Tyne
    Mayborn House
    United Kingdom
    Administrateur
    Balliol Business Park
    NE12 8EW Newcastle Upon Tyne
    Mayborn House
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector220648350001
    BREWER, Suzanne
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B2 5DN Birmingham
    Secrétaire désigné
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B2 5DN Birmingham
    British900004890001
    GOUGH, David John
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    Secrétaire
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    159716370001
    HOLMES, Ouvrielle
    The Old Rectory
    Aveton Gifford
    TQ7 4LG Kingsbridge
    Devon
    Secrétaire
    The Old Rectory
    Aveton Gifford
    TQ7 4LG Kingsbridge
    Devon
    BritishCompany Secretary69442890001
    WILLIAMS, Jennifer Christine
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    Secrétaire
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    BritishDirector75705680001
    MICHELMORES SECRETARIES LIMITED
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    Secrétaire
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03834235
    107218000001
    BREWER, Kevin, Dr
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    Administrateur désigné
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    EnglandBritish900004880001
    DENNING, Edward Timothy
    South Knighton House
    South Knighton
    TQ12 6NP Newton Abbot
    Devon
    Administrateur
    South Knighton House
    South Knighton
    TQ12 6NP Newton Abbot
    Devon
    BritishDirector104305230001
    GOUGH, David John
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    Administrateur
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director134326940002
    HOLMES, Ouvrielle
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    Administrateur
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    United KingdomBritishCompany Director69442890001
    HOLMES, Robert Douglas
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    Administrateur
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    UkBritishCompany Director69442940001
    JONES, Christian Taylor
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    Administrateur
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director174405210001
    WESTERMAN, Laetitia
    1 Davis Cottages
    Butterleigh
    EX15 1PN Cullompton
    Devon
    Administrateur
    1 Davis Cottages
    Butterleigh
    EX15 1PN Cullompton
    Devon
    FrenchDirector112343450001
    WILLIAMS, Jennifer Christine
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    Administrateur
    Linhay Business Park
    Ashburton
    TQ13 7UP Devon
    EnglandBritishDirector75705680001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GRO-GROUP UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gro-Group Limited
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Pynes Hill
    EX2 5WR Exeter
    Woodwater House
    Devon
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GRO-GROUP UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 mai 2013
    Livré le 07 mai 2013
    En cours
    Brève description
    N/A. notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Loan note instrument
    Créé le 14 mars 2013
    Livré le 21 mars 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any or all of the obligors to the stockholders and/or the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Robert Holmes and Ouvrielle Holmes (Together the ("Security Trustee")
    Transactions
    • 21 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Guarantee and debenture
    Créé le 14 mars 2013
    Livré le 19 mars 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from michco 1209 limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mobeus Equity Partners LLP
    Transactions
    • 19 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 01 août 2005
    Livré le 02 août 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transactions
    • 02 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 août 2003
    Livré le 28 août 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 janv. 2001
    Livré le 17 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 sept. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0