CORTEX DISPLAYS LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCORTEX DISPLAYS LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03971569
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CORTEX DISPLAYS LTD ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe CORTEX DISPLAYS LTD ?

    Adresse du siège social
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CORTEX DISPLAYS LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLUIDWELL (UK) LTD13 avr. 200013 avr. 2000

    Quels sont les derniers comptes de CORTEX DISPLAYS LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour CORTEX DISPLAYS LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2022

    10 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2022 au 30 sept. 2022

    1 pagesAA01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    11 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2018

    11 pagesAA

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Graham Joseph Morrell en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee Alfred Brogan le 27 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Steven Richard Weeks en tant que secrétaire le 29 août 2017

    1 pagesTM02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Lee Alfred Brogan le 07 juin 2017

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    19 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 avr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Graham Joseph Morrell en tant qu'administrateur le 13 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Graham Ernest Nel en tant que directeur le 13 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CORTEX DISPLAYS LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROGAN, Lee Alfred
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishSales And Marketing95127460007
    BUXTON, Laura Gillian
    Moatfields
    Wood End
    MK17 0PE Little Horwood
    Bucks
    Secrétaire
    Moatfields
    Wood End
    MK17 0PE Little Horwood
    Bucks
    British92211810005
    PETER, Lapicki
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    164687460001
    TERRY, Matthew Simon
    Forge Lane
    Minworth Industrial Park, Minworth
    B76 1AH Sutton Coldfield
    Unit 41
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    Forge Lane
    Minworth Industrial Park, Minworth
    B76 1AH Sutton Coldfield
    Unit 41
    West Midlands
    United Kingdom
    157462850001
    WEBSTER, Patricia Anne
    Long Haul-43 Main Street
    Weston Turville
    HP22 5RW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Long Haul-43 Main Street
    Weston Turville
    HP22 5RW Aylesbury
    Buckinghamshire
    British69952800001
    WEEKS, Steven Richard
    Boston Drive
    SL8 5YS Bourne End
    7/8 Eghams Court
    Buckinghamshire
    England
    Secrétaire
    Boston Drive
    SL8 5YS Bourne End
    7/8 Eghams Court
    Buckinghamshire
    England
    191038170001
    TEMPLES (NOMINEES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Secrétaire désigné
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004500001
    BUXTON, Laura Gillian
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Unit 7 Swan Business Centre
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishLecturer92211810005
    MORRELL, Graham Joseph
    Boston Drive
    SL8 5YS Bourne End
    7/8 Eghams Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Boston Drive
    SL8 5YS Bourne End
    7/8 Eghams Court
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector198181930001
    NEL, Graham Ernest
    Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    58
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Rewley Road
    OX1 2RQ Oxford
    58
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector60720170002
    TERRY, Matthew Simon
    Minworth Industrial Park
    Forge Lane, Minworth
    B76 1AH Sutton Coldfield
    Unit 41
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Minworth Industrial Park
    Forge Lane, Minworth
    B76 1AH Sutton Coldfield
    Unit 41
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector156087040001
    WEBSTER, Donald Maurice
    43 Main Street
    Weston Turville
    HP22 5RW Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    43 Main Street
    Weston Turville
    HP22 5RW Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishSystems Engineer53665220001
    TEMPLES (PROFESSIONAL SERVICES) LIMITED
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    Administrateur désigné
    152 City Road
    EC1V 2NX London
    900004490001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CORTEX DISPLAYS LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bell Flow Systems Limited
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Unit 7 Swan Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    06 avr. 2016
    Osier Way
    MK18 1TB Buckingham
    Unit 7 Swan Business Centre
    Buckinghamshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleEnglish
    Lieu d'enregistrementRegistered Office
    Numéro d'enregistrement03386045
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CORTEX DISPLAYS LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 avr. 2015
    Livré le 17 avr. 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 17 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 26 nov. 2012
    Livré le 05 déc. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 06 juin 2011
    Livré le 10 juin 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 10 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 03 févr. 2011
    Livré le 04 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0