BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED

BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBMHL REALISATIONS 2016 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03977289
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Four
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Westmidlands
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERNARD MATTHEWS HOLDINGS LIMITED02 avr. 200102 avr. 2001
    BERNARD MATTHEWS LIMITED22 févr. 200122 févr. 2001
    BERNARD MATTHEWS HOLDINGS PLC24 oct. 200024 oct. 2000
    LEGISLATOR 1473 LIMITED20 avr. 200020 avr. 2000

    Quels sont les derniers comptes de BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 juin 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    24 pagesAM23

    Cessation de la nomination de Zaliha Williamson en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Robert Burnett en tant que directeur le 30 juin 2017

    1 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 19 mars 2017

    20 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    43 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    44 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Great Witchingham Hall Great Witchingham Norwich NR9 5QD à Four Brindley Place Birmingham Westmidlands B1 2HZ le 04 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Yvonne Catherine Mary Goldingham en tant que secrétaire le 18 août 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 juin 2016

    État du capital au 20 juin 2016

    • Capital: GBP 13,234,452.99489
    SH01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de David John Joll en tant que directeur le 06 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Alan Rae Dalziel Jamieson en tant qu'administrateur le 29 mars 2016

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 28 juin 2015

    38 pagesAA

    Inscription de la charge 039772890008, créée le 28 août 2015

    81 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 13,234,452.99489
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de Bernard Matthews Ltd Great Witchingham Hall Norwich Norfolk NR9 5QD à Great Witchingham Hall Great Witchingham Norwich NR9 5QD le 17 juin 2015

    1 pagesAD01

    Comptes consolidés établis au 29 juin 2014

    38 pagesAA

    Nomination de Mr Robert Burnett en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 juin 2014

    État du capital au 05 juin 2014

    • Capital: GBP 13,234,452.99489
    SH01

    Nomination de Mrs Zaliha Williamson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JAMIESON, Alan Rae Dalziel
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Westmidlands
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Westmidlands
    EnglandBritish31138330004
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    England
    Secrétaire
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    England
    172058450001
    GOLDINGHAM, Yvonne Catherine Mary
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    170469160001
    HARRISON, Neil Charles
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    British111081410001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Secrétaire désigné
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    British900008180001
    REGER, David Michael
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    171032740001
    REGER, David Michael
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    British151343430001
    AMERIGO, Lee Robert
    74a Gloucester Street
    NR2 2DY Norwich
    Administrateur désigné
    74a Gloucester Street
    NR2 2DY Norwich
    British900020250001
    BARTRAM, Noel Frederick
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish37442010003
    BURNETT, Robert
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Westmidlands
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Westmidlands
    ScotlandBritish86190250002
    CLAUSSEN, Carolyn Dawn
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish107828530001
    CROSS, Neil Earl, Doctor
    2 The Heights, Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    2 The Heights, Brooklands
    KT13 0NY Weybridge
    Surrey
    British7308500007
    DALLA MURA, Bart Wallace
    Epwell Grounds
    OX15 6HF Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Epwell Grounds
    OX15 6HF Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish113217530001
    ELGERSHUIZEN, George Frederick Bernard
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    United Kingdom
    The NetherlandsDutch160594860001
    HARRISON, Neil Charles
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bramley House
    The Loke Cringleford
    NR4 6XA Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish111081410001
    JOLL, David John
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    England
    Administrateur
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    England
    United KingdomBritish178372710001
    JOLL, David John
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    Administrateur
    Irmingland Hall
    Corpusty
    NR11 6QF Holt
    Norfolk
    United KingdomBritish178372710001
    LUNN, George Michael
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish194960002
    MATTHEWS, Bernard Trevor
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish10918210001
    MATTHEWS, Joyce Kathleen
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish160594930001
    MATTHEWS, Joyce Kathleen
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    United Kingdom
    Administrateur
    Great Witchingham
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    United Kingdom
    EnglandBritish160594930001
    MCCALL, David Slesser
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Bernard Matthews Ltd
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish60326440001
    MEARS, Robert Michael
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    England
    Administrateur
    Great Witchingham Hall
    NR9 5QD Norwich
    Norfolk
    England
    EnglandBritish136995510002
    NEWTON, David Alexander
    Falcon House
    Mellis
    IP23 8DS Eye
    Suffolk
    Administrateur
    Falcon House
    Mellis
    IP23 8DS Eye
    Suffolk
    British81588700001
    PICKERSGILL, Dominic James
    72 Stafford Street
    NR2 3BG Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    72 Stafford Street
    NR2 3BG Norwich
    Norfolk
    British60834690001
    POOLEY, Maureen
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    Administrateur désigné
    12 Lodge Lane
    Old Catton
    NR6 7HG Norwich
    Norfolk
    British900008180001
    SIMPSON, Andrew John
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    England
    Administrateur
    NR9 5QD Norwich
    Great Witchingham Hall
    Norfolk
    England
    EnglandBritish105165150001
    WILLIAMSON, Zaliha
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Westmidlands
    Administrateur
    Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Four
    Westmidlands
    EnglandBritish323983980001

    BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 août 2015
    Livré le 03 sept. 2015
    En cours
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture creating fixed and floating charges over all the assets and undertakings (present and future) of bernard matthews holdings limited.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 03 sept. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 30 août 2013
    Livré le 05 sept. 2013
    En cours
    Brève description
    As more particularly described in clause 3 of the debenture, a debenture taking fixed and floating charges over all the assets and undertaking (present and future) of bernard matthews holdings limited.. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rutland Partners LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 05 sept. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Deed of amendment and accession
    Créé le 20 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due up to a liability of £12,500,000 from the company to bernard matthews pensions fund
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Security over cash deposits
    Créé le 11 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit in the account presently being £2,054,891. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of debenture
    Créé le 11 juin 2007
    Livré le 21 juin 2007
    En cours
    Montant garanti
    The first ranking secured liabilities and the second ranking secured liabilities under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Burdale Financial Limited
    Transactions
    • 21 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 15 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • De Lage Landen Ireland Company
    Transactions
    • 15 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 08 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transactions
    • 08 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A security agreement
    Créé le 25 oct. 2000
    Livré le 13 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligor (as defined) to any finance party (as defined) under each finance document (as defined)
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all plant and machinery any plant or machinery, charged shares and their related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC (The "Agent")
    Transactions
    • 13 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BMHL REALISATIONS 2016 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 sept. 2016Administration started
    30 oct. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul James Meadows
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    practitioner
    4 Brindley Place
    B1 2HZ Birmingham
    Richard Michael Hawes
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    practitioner
    5 Callaghan Square
    CF10 5BT Cardiff
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0