KEW GREEN HOTELS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKEW GREEN HOTELS LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03993178
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration

    Où se situe KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Bdo Llp 5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2018
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2019
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 mai 2020
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 mai 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mai 2024

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mai 2023

    18 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mai 2022

    pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU à C/O Bdo Llp 5 Temple Square Temple Street Liverpool L2 5RH le 01 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mai 2021

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 22 mai 2020

    13 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de Suite 17 Building 6 Croxley Park Hatters Lane Watford Hertfordshire WD18 8YH à Bdo Llp 55 Baker Street London W1U 7EU le 20 févr. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    7 pagesLIQ10

    Changement d'adresse du siège social de 1 Towers Place Eton Street Richmond Surrey TW9 1EG England à Suite 17 Building 6 Croxley Park Hatters Lane Watford Hertfordshire WD18 8YH le 10 juin 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 23 mai 2019

    LRESSP

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Jameson Andrew Lamb le 01 juil. 2016

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jameson Andrew Lamb le 31 août 2013

    2 pagesCH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 21 mai 2019

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 15 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    21 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 18 déc. 2018

    • Capital: GBP 467,752.00
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduction of share premium account 12/12/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Qui sont les dirigeants de KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LAMB, Jameson Andrew
    5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp
    Secrétaire
    5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp
    British105312540001
    LAMB, Jamie Andrew
    5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp
    Administrateur
    5 Temple Square
    Temple Street
    L2 5RH Liverpool
    C/O Bdo Llp
    EnglandBritishFinance Director185775970001
    PRITCHARD, Alex Edward
    Towers Place
    Eton Street
    TW9 1EG Richmond
    1
    Surrey
    England
    Administrateur
    Towers Place
    Eton Street
    TW9 1EG Richmond
    1
    Surrey
    England
    EnglandBritishDirector209546940001
    HUTCHINSON, Richard Eugene
    Wheatcroft Roseacre Barns
    Pimlico
    HP3 8SF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Wheatcroft Roseacre Barns
    Pimlico
    HP3 8SF Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British56986650002
    RICHARDSON, Jeremy Robert Arthur
    16 Wimborne Gardens
    Ealing
    W13 8BZ London
    Secrétaire
    16 Wimborne Gardens
    Ealing
    W13 8BZ London
    BritishCompany Director95661150001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Secrétaire désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    JOHNSON, Paul Daniel
    28 Pyrmont Road
    W4 3NR London
    Administrateur
    28 Pyrmont Road
    W4 3NR London
    United KingdomBritishCompany Director81052450001
    RICHARDSON, Jeremy Robert Arthur
    16 Wimborne Gardens
    Ealing
    W13 8BZ London
    Administrateur
    16 Wimborne Gardens
    Ealing
    W13 8BZ London
    United KingdomBritishCompany Director95661150001
    SIDWELL, Graham Robert
    1 Stanley Mansions
    Park Walk
    SW10 0AG London
    Administrateur
    1 Stanley Mansions
    Park Walk
    SW10 0AG London
    United KingdomBritishCompany Director72844280004
    STANLEY, Graham Bryan
    Foxwood
    11 Burwood Road
    KT12 5BS Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Foxwood
    11 Burwood Road
    KT12 5BS Walton On Thames
    Surrey
    United KingdomBritishAlternate Director46112880007
    TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    United KingdomAustrianCompany Director11820520001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Administrateur désigné
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KEW GREEN HOTELS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    China National Travel Service Group Corporation
    78-83 Connaught Road Central
    Hong Kong
    Cts House
    China
    06 avr. 2016
    78-83 Connaught Road Central
    Hong Kong
    Cts House
    China
    Non
    Forme juridiqueGovernment Department
    Autorité légaleChina Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    KEW GREEN HOTELS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 janv. 2015
    Livré le 27 janv. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Remich Holding Ii S.A.R.L.
    Transactions
    • 27 janv. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 10 août 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 06 août 2014
    Livré le 08 août 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 mars 2011
    Livré le 15 mars 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of keyman insurance policies
    Créé le 05 mai 2009
    Livré le 07 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group member to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the policies: paul daniel johnson p/no 6576-2TA-dys assuring the sum of £500,000. jameson andrew lamb p/no 6572-2TA-dys assuring the sum of £500,000. jeremy robert arthur richardson p/no 6574-2TA-dys assuring the sum of £500,000. and all rights and remedies in connection with the policies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties) (the Security Agent)
    Transactions
    • 07 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 nov. 2008
    Livré le 13 nov. 2008
    En cours
    Montant garanti
    £15,412.48 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The sum of £15,412.48 and all sums paid under the rent deposit deed see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peel South East Limited
    Transactions
    • 13 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Security interest agreement
    Créé le 30 oct. 2008
    Livré le 07 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured party and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigned title to the affected securities to the secured party meaning the shares and all right, title, benefit and interest therein. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent for the Secured Parties)(Secured Party)
    Transactions
    • 07 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 oct. 2008
    Livré le 07 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security agent and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent for the Secured Parties)(Security Agent)
    Transactions
    • 07 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Security interest agreement
    Créé le 14 févr. 2007
    Livré le 24 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The affected securities being 100,000 ordinary shares of £1 each in the company and all rights. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 févr. 2007
    Livré le 24 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 nov. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 sept. 2001
    Livré le 02 oct. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any security beneficiary (as defined in the debenture) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 oct. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    KEW GREEN HOTELS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 mai 2019Commencement of winding up
    23 mai 2019Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James Eldridge
    Suite 17 Building 6 Croxley Green Business Park
    Hatters Lane
    WD18 8YH Watford
    Hertfordshire
    practitioner
    Suite 17 Building 6 Croxley Green Business Park
    Hatters Lane
    WD18 8YH Watford
    Hertfordshire
    Jeremy Mark Willmont
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Stacey Brown
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0