COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03997349
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    • Autres activités d'édition de logiciels (58290) / Information et communication
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AXIOM SYSTEMS HOLDINGS LIMITED25 sept. 200025 sept. 2000
    BANDRIVER LIMITED19 mai 200019 mai 2000

    Quels sont les derniers comptes de COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    9 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 août 2022

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 août 2021

    11 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de One Forbury Square the Forbury Reading Bershire RG1 3EB à 25 Farringdon Street London EC4A 4AB le 21 sept. 2020

    2 pagesAD01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 août 2020

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 17 juil. 2020

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 07/07/2020
    RES13

    Modification des coordonnées de l'administrateur Kelly Melissa Archer le 11 nov. 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Kelly Melissa Archer en tant qu'administrateur le 11 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Antti Akseli Koskela en tant que directeur le 11 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 10 oct. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Nokia Corporation en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 juin 2017

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 07 oct. 2019

    2 pagesPSC09

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2018 au 30 juin 2019

    1 pagesAA01

    Nomination de Citco Management (Uk) Limited en tant que secrétaire le 01 avr. 2019

    2 pagesAP04

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 7 Albemarle Street London W1S 4HQ

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT United Kingdom à 7 Albemarle Street London W1S 4HQ

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Sami Kimmo Johannes Ahonen en tant que directeur le 30 avr. 2019

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CITCO MANAGEMENT (UK) LIMITED
    Albemarle Street
    W1S 4HQ London
    7 Albemarle Street
    England
    Secrétaire
    Albemarle Street
    W1S 4HQ London
    7 Albemarle Street
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement02656801
    74414520001
    ARCHER, Kelly Melissa
    Arlington Business Park
    RG7 4SA Theale
    The Hive
    United Kingdom
    Administrateur
    Arlington Business Park
    RG7 4SA Theale
    The Hive
    United Kingdom
    United KingdomBritishController111861920003
    OSBORNE, Simon John
    Stanstead Road
    CR3 6AB Caterham
    92
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Stanstead Road
    CR3 6AB Caterham
    92
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishVice President, Products And Solutions164401090001
    VINCENT-FERNIE, Michael Guy
    Kelsall Lodge Bagshot Road
    Sunninghill
    SL5 9JJ Ascot
    Berkshire
    Secrétaire
    Kelsall Lodge Bagshot Road
    Sunninghill
    SL5 9JJ Ascot
    Berkshire
    BritishManaging Director13722370003
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AHONEN, Sami Kimmo Johannes
    Espoo
    Kirvuntie 39
    02140
    Finland
    Administrateur
    Espoo
    Kirvuntie 39
    02140
    Finland
    FinlandFinnishSenior Vice President, Legal And M&A130736400001
    BOWER, Whitney
    12 East 88th Street
    Apt 12a
    New York
    New York 10128
    Usa
    Administrateur
    12 East 88th Street
    Apt 12a
    New York
    New York 10128
    Usa
    AmericanGen Partner Venture Capital71848290001
    CLEARMAN, Stephen Joshua
    280 Lydecker Street
    Englewood
    New Jersey 07631
    Usa
    Administrateur
    280 Lydecker Street
    Englewood
    New Jersey 07631
    Usa
    BritishInvestment Manager79361580001
    EVANS, Alexander Robert
    Garden House Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Garden House Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director91448370001
    GORDON, Jeffrey Philip
    2 Hamlyn Close
    HA8 8DB Edgware
    Middlesex
    Administrateur
    2 Hamlyn Close
    HA8 8DB Edgware
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director75424710002
    HUMPHRIES, Nicholas James
    43 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Administrateur
    43 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    BritishVenture Capitalist57329660001
    HUMPHRIES, Nicholas James
    43 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Administrateur
    43 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    BritishVenture Capital57329660001
    KOSKELA, Antti Akseli
    00180 Helsinki
    Salmisaarenaukio 1
    Finland
    Administrateur
    00180 Helsinki
    Salmisaarenaukio 1
    Finland
    FinlandFinnishSenior Vice President, Products And Solutions164427880001
    MAY, Beverley
    47 Imperial Way
    RG19 4RS Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    47 Imperial Way
    RG19 4RS Thatcham
    Berkshire
    BritishAccountant116870710001
    MORGAN, Ian Glyn
    Millstream Cottage
    Ryehurst Lane, Binfield
    RG42 5QY Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream Cottage
    Ryehurst Lane, Binfield
    RG42 5QY Bracknell
    Berkshire
    BritishTechnical Director69737360001
    PRYTULA, Justina
    3 Tern Close
    Gabriel Park
    RG22 5UF Basingstoke
    Administrateur
    3 Tern Close
    Gabriel Park
    RG22 5UF Basingstoke
    United KingdomBritishAccountant68795120003
    SAASKILAHTI, Simo Antti
    02230 Espoo
    Lirislahdentie 47 B 5
    Finland
    Administrateur
    02230 Espoo
    Lirislahdentie 47 B 5
    Finland
    FinnishSenior Vice President, Corporate Development130736880002
    SENIOR, Gareth James
    Fern House
    128 Locks Ride
    SL5 8QX Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Fern House
    128 Locks Ride
    SL5 8QX Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer69737320002
    SMITH, Rosalind, Dr
    Broad Green Farm
    Chrishall
    SE8 8QR Royson
    Herts
    Administrateur
    Broad Green Farm
    Chrishall
    SE8 8QR Royson
    Herts
    BritishNon Exec Director120655810001
    VINCENT-FERNIE, Michael Guy
    Kelsall Lodge Bagshot Road
    Sunninghill
    SL5 9JJ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Kelsall Lodge Bagshot Road
    Sunninghill
    SL5 9JJ Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishExecutive Chairman13722370003
    WATSON, Mark
    Mallards
    Gracious Pond Road
    GU24 8EX Chobham
    Surrey
    Administrateur
    Mallards
    Gracious Pond Road
    GU24 8EX Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director76299860001
    ZIEMNIAK, Czeslaw John
    Whiteposts
    Walkwood End
    HP9 1PR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Whiteposts
    Walkwood End
    HP9 1PR Beaconsfield
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director79361600001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Nokia Corporation
    Karakaari
    02610 Espoo
    7
    Finland
    29 juin 2017
    Karakaari
    02610 Espoo
    7
    Finland
    Non
    Forme juridiquePublic Limited Company
    Pays d'enregistrementFinland
    Autorité légaleLaws Of The Republic Of Finland Under The Constitution Of The Republic Of Finland
    Lieu d'enregistrementThe Finnish Trade Register
    Numéro d'enregistrement0112038-9
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    10 oct. 201604 oct. 2019La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 mai 2007
    Livré le 01 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Etv Capital S.A.
    Transactions
    • 01 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 juil. 2006
    Livré le 31 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monie due or to become due from the company and axiom systems limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge the property intellectual property shares and derivative assets goodwill uncalled capital floating charge all the undertaking and assets whatsoever including without limitation the contracts the book debts the plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Etv Capital S.A.
    Transactions
    • 31 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 14 avr. 2003
    Livré le 25 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hg Investment Managers Limited(As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transactions
    • 25 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 23 déc. 2002
    Livré le 23 déc. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future moneys debts and liabilities due or to become due from the company to any lender under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge its undertaking and all its assets both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Hg Investment Managers Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 23 déc. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 05 mars 2001
    Livré le 13 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Barclays bank PLC re axiom systems holdings limited barclays treasury deposit deal number 67246566. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 17 nov. 2000
    Livré le 28 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    79160466. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 28 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    COMPTEL COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    28 mars 2023Due to be dissolved on
    19 août 2020Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Ann Spears
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    9th Floor, 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    practitioner
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0