SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED

SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 03998112
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Henkel Limited
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HAMSARD 2200 LIMITED19 mai 200019 mai 2000

    Quels sont les derniers comptes de SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Application to strike off 03/05/2023
    RES13

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Peter David Budden en tant que directeur le 10 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Liam Anthony Murphy en tant que directeur le 10 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2015

    État du capital au 19 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de Apollo Court 2 Bishop Square Business Park Hatfield Herts AL10 9EY à Henkel Limited Wood Lane End Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4RQ le 23 juil. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 mai 2014

    État du capital au 19 mai 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter David Budden le 21 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Sutinder Bhandal en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de David Graham en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BHANDAL, Sutinder
    Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    5
    Warwickshire
    Uk
    Secrétaire
    Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    5
    Warwickshire
    Uk
    British174260500001
    BHANDAL, Sutinder Singh
    5 Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    Administrateur
    5 Hopton Crofts
    CV32 6NT Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    United KingdomBritish113815020001
    GRAHAM, David Richard
    32 Monkhams Lane
    IG8 0NS Woodford Green
    Essex
    Secrétaire
    32 Monkhams Lane
    IG8 0NS Woodford Green
    Essex
    British7345980001
    STEWARD, Andrew
    8 Carrion View
    S81 8YZ Gateford
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    8 Carrion View
    S81 8YZ Gateford
    Nottinghamshire
    British73836180002
    BUDDEN, Peter David
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Henkel Limited
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Wood Lane End
    HP2 4RQ Hemel Hempstead
    Henkel Limited
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish114395690003
    CORK, James William
    1 Marlborough Court
    NG24 4PT Newark
    Nottinghamshire
    Administrateur
    1 Marlborough Court
    NG24 4PT Newark
    Nottinghamshire
    British73836260001
    COVALT, Robert Byron
    7517 West Bull Valley
    Road
    Mchenry
    Illinois 60050
    Usa
    Administrateur
    7517 West Bull Valley
    Road
    Mchenry
    Illinois 60050
    Usa
    American5288740001
    HOWELL JONES, Martin
    3 Peacock Court
    20 South Park Road
    SW19 8SX Wimbledon
    Administrateur
    3 Peacock Court
    20 South Park Road
    SW19 8SX Wimbledon
    EnglandBritish79974450001
    JARVIS, Timothy Hugh
    2 Park Lane
    LS3 1ES Leeds
    Administrateur
    2 Park Lane
    LS3 1ES Leeds
    British72690800001
    MEIER, Anke
    Simon Meister Strasse 13
    50733 Cologne
    Germany
    Administrateur
    Simon Meister Strasse 13
    50733 Cologne
    Germany
    British95320690002
    MURPHY, Liam Anthony
    St Joseph's Avenue
    Station Road
    IRISH Newbridge
    County Kildare
    Ireland
    Administrateur
    St Joseph's Avenue
    Station Road
    IRISH Newbridge
    County Kildare
    Ireland
    IrelandIrish95686630001
    PACE, Louis Michael
    2607 W Huron Street
    FOREIGN Chicago
    60612 Illinois
    Usa
    Administrateur
    2607 W Huron Street
    FOREIGN Chicago
    60612 Illinois
    Usa
    American72627550002
    SMITH, Terry Dan
    155 Samoa Drive
    Akron
    Ohio 44319
    United States
    Administrateur
    155 Samoa Drive
    Akron
    Ohio 44319
    United States
    United StatesAmerican164946460001
    HAMMOND SUDDARDS DIRECTORS LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Administrateur désigné
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008740001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    Administrateur désigné
    7 Devonshire Square
    EC2M 4YH London
    900008750001

    SOVEREIGN SPECIALTY CHEMICALS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 juin 2002
    Livré le 26 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jp Morgan Chase Bank as Security Trustee for the Secured Parties (The "Administrative Agent")
    Transactions
    • 26 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Share pledge agreement
    Créé le 30 nov. 2000
    Livré le 11 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and obligations due from the company to the chargee and/or the secured parties under the credit agreement and other loan documents (as defined)
    Brèves mentions
    185 registered shares of the company numbered from 1 to 185 (the shares) any dividends and any other monies which would be due to the holder of the shares.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank the (Administrative Agent) as Security Trustee Foritself and the Other Agents Lender Parties and Hedge Banks Banks (as Defined)
    Transactions
    • 11 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Quota pledge agreement
    Créé le 24 nov. 2000
    Livré le 11 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Us$93,587.00 Which amount was borrowed by the company from the lenders and advanced to the company as an intercompany loan to fund the company's purchase of certain assets of croda italiana spa as part of the croda acquisition as defined
    Brèves mentions
    A continuing first priority security interest in and to all of the right title and interest of the pledgor in the quotas under clause 2 of the pledge under clause 5 of the pledge it was agreed that the pledge constitutes a continuing security to the pledgee for the secured obligations. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bank for Its Own Account and on Behalf of Certainlenders
    Transactions
    • 11 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 31 oct. 2000
    Livré le 08 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the secured parties and/or any reciever under or in connection with the loan documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Chase Manhattan Bankthe ("Administrative Agent") as Security Trustee for Itself and the Other Agents, Lender Parties and Hedge Banks (As Defined)
    Transactions
    • 08 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0