PROMOTIONAL ITEMS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PROMOTIONAL ITEMS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 03998138 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PROMOTIONAL ITEMS LIMITED ?
Adresse du siège social | Unit 2 Woking 8 Forsyth Road GU21 5SB Woking England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PROMOTIONAL ITEMS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour PROMOTIONAL ITEMS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3 River Court Albert Drive Woking Surrey GU21 5RP à Unit 2 Woking 8 Forsyth Road Woking GU21 5SB le 18 juil. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2018 au 30 juin 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Carr-Hill Limited en tant que secrétaire le 03 août 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Anthony Sowerby en tant que directeur le 03 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 2 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 19 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Stuart Neil Ross en tant que directeur le 13 févr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de George Goodfellow en tant que directeur le 13 févr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2-4 Cobb House Oyster Lane Byfleet Surrey KT14 7HQ à 3 River Court Albert Drive Woking Surrey GU21 5RP le 04 févr. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013 | 3 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 19 mai 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PROMOTIONAL ITEMS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYNN, David Peter | Administrateur | Woking 8 Forsyth Road GU21 5SB Woking Unit 2 England | United Kingdom | British | Director | 160711840001 | ||||||||
BEDROSSIAN, Barrett | Secrétaire | 47 Belmont Road WD23 2JR Bushey Hertfordshire | British | Finance Director | 113609690001 | |||||||||
FIELDER, Barry William | Secrétaire | 6 Queensborough House South 18 Oatlands Chase KT13 9SF Weybridge Surrey | British | Accountant | 102177520001 | |||||||||
SCOTT, Susan Margaret | Secrétaire | Poyle Place Holywell DT2 0LL Dorchester Dorset | British | 70146790001 | ||||||||||
SMITH, David Robert | Secrétaire | Severus Avenue YO24 4LX York 7 North Yorkshire United Kingdom | British | Finance Director | 138589800001 | |||||||||
SYKES, Timothy James | Secrétaire | 19 Sand Hutton YO41 1LB York The Fleetings North Yorkshire | British | Director | 134824900001 | |||||||||
VARLEY, Martin | Secrétaire | Oyster Lane KT14 7HQ Byfleet 2-4 Cobb House Surrey | British | Director | 138736760001 | |||||||||
CARR-HILL LIMITED | Secrétaire | Carr Hill Road Upper Cumberworth HD8 8XN Huddersfield 49a West Yorkshire England |
| 285506070001 | ||||||||||
CDF SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secrétaire désigné | 188/196 Old Street EC1V 9FR London | 900014680001 | |||||||||||
ASPINAL, Garry | Administrateur | 105 Oakdale Drive Heald Green SK8 3SN Cheadle Cheshire | British | Director | 122708800001 | |||||||||
BEDROSSIAN, Barrett | Administrateur | 47 Belmont Road WD23 2JR Bushey Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 113609690001 | ||||||||
GOODFELLOW, George | Administrateur | Albert Drive GU21 5RP Woking 3 River Court Surrey England | England | British | Director | 160711860001 | ||||||||
ROSS, Stuart Neil | Administrateur | Albert Drive GU21 5RP Woking 3 River Court Surrey England | United Kingdom | British | Director | 161719140001 | ||||||||
SCOTT, Michael Edward | Administrateur | Poyle Place Holywell DT2 0LL Dorchester Dorset | England | British | Principal Partner | 70146730001 | ||||||||
SLATER, Richard Craig Alan | Administrateur | Westleigh Stannage Lane Churton CH3 6LE Chester | United Kingdom | British | Director | 37111560008 | ||||||||
SMITH, David Robert | Administrateur | Severus Avenue YO24 4LX York 7 North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 138589800001 | ||||||||
SOWERBY, Richard Anthony | Administrateur | Albert Drive GU21 5RP Woking 3 River Court Surrey England | England | British | Director | 60728080002 | ||||||||
SYKES, Timothy James | Administrateur | 19 Sand Hutton YO41 1LB York The Fleetings North Yorkshire | England | British | Director | 134824900001 | ||||||||
CDF FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 188/196 Old Street EC1V 9FR London | 900014670001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROMOTIONAL ITEMS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dowlis Inspired Branding Limited | 06 avr. 2016 | River Court, Albert Drive GU21 5RP Woking 3 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
PROMOTIONAL ITEMS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 12 juil. 2011 Livré le 21 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any charging company to the chargee or the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite all assets guarantee and indemnity and debenture | Créé le 12 juil. 2011 Livré le 16 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0