IFF FILMS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIFF FILMS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04005564
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IFF FILMS LIMITED ?

    • Activités de production de films cinématographiques (59111) / Information et communication

    Où se situe IFF FILMS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    33b Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IFF FILMS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    IPSO FACTO FILMS LIMITED13 avr. 200313 avr. 2003
    IPSO FACTO FILMS (A FILM ABOUT BRIDES) LIMITED01 juin 200001 juin 2000

    Quels sont les derniers comptes de IFF FILMS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour IFF FILMS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour IFF FILMS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juin 2016

    État du capital au 21 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 7-15 Pink Lane 2nd Floor Suite 24 Newcastle upon Tyne NE1 5DW à 33B Cresswell Road Twickenham TW1 2EA le 08 mars 2016

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2015

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 juin 2015

    État du capital au 16 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2014

    3 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Christine Alderson le 01 nov. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Christine Alderson le 01 nov. 2014

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 juin 2014

    État du capital au 03 juin 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Christine Alderson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Christine Alderson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Christine Alderson le 01 janv. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2011

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Hayley Manning en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Ms Loraine Biggins en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mars 2010

    3 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * 1 Pink Lane Newcastle NE1 5DW* le 13 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de IFF FILMS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ALDERSON, Christine
    Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    33b
    England
    Secrétaire
    Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    33b
    England
    British158594460001
    BIGGINS, Loraine
    Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    33b
    England
    Secrétaire
    Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    33b
    England
    157850430001
    ALDERSON, Christine Mary
    Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    33b
    England
    Administrateur
    Cresswell Road
    TW1 2EA Twickenham
    33b
    England
    EnglandBritishCompany Secretary158594460005
    ALDERSON, Christine
    Flat 6 Glenmore House
    64 Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond Hill
    Surrey
    Secrétaire
    Flat 6 Glenmore House
    64 Richmond Hill
    TW10 6BQ Richmond Hill
    Surrey
    BritishCompany Secretary158594460001
    BREWER, Suzanne
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B2 5DN Birmingham
    Secrétaire désigné
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B2 5DN Birmingham
    British900004890001
    TODESCATO-RUTLAND, Samantha
    70 Birkbeck Road
    DA14 4DW Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    70 Birkbeck Road
    DA14 4DW Sidcup
    Kent
    BritishAccountant80130550002
    BOWDEN, Steve Raymond
    2 South Avenue
    NE14 3LD Ryton
    Administrateur
    2 South Avenue
    NE14 3LD Ryton
    BritishCompany Director89068100002
    BREWER, Kevin, Dr
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    Administrateur désigné
    Somerset House
    40-49 Price Street
    B4 6LZ Birmingham
    EnglandBritish900004880001
    ISITT, Deborah Ann
    36 Sydnall Road
    Longford
    CV6 6BW Coventry
    West Midlands
    Administrateur
    36 Sydnall Road
    Longford
    CV6 6BW Coventry
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director114381790002
    MANNING, Hayley Lynne
    Rectory Cottage
    NE40 3QA Ryton Village
    2
    Tyne And Wear
    Administrateur
    Rectory Cottage
    NE40 3QA Ryton Village
    2
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishDirector114620570002

    IFF FILMS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 juil. 2007
    Livré le 10 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 28 nov. 2006
    Livré le 11 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the security debenture amount and interest accrued thereon receivable by the charger in respect of the film (spin the bottle) from the chargee under the security debenture agreement dated 28TH november 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jp Capital Inc.,
    Transactions
    • 11 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 28 nov. 2006
    Livré le 11 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the security debenture amount and interest accrued thereon receivable by the charger in respect of the film (short order) from the chargee under the security debenture agreement dated 28TH november 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jp Capital Inc.,
    Transactions
    • 11 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Charge
    Créé le 28 nov. 2006
    Livré le 11 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right, title and interest in and to the security debenture amount and interest accrued thereon receivable by the charger in respect of the film (miss montigny) from the chargee under the security debenture agreement dated 28TH november 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jp Capital Inc.,
    Transactions
    • 11 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 01 oct. 2000
    Livré le 11 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 nov. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0