ENRICHTECH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéENRICHTECH LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04005588
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ENRICHTECH LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe ENRICHTECH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jubilee House, Second Avenue
    Burton Upon Trent
    DE14 2WF Staffordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ENRICHTECH LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le11 août 2022
    Date d'échéance des prochains comptes11 mai 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au15 août 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ENRICHTECH LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juin 2023
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 juin 2023
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juin 2022
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour ENRICHTECH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2024

    9 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    4 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2023

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    État du capital au 09 mars 2023

    • Capital: GBP 1
    6 pagesSH19

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    legacy

    2 pagesSH20

    Statuts

    8 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re: removal of various directors / appointment of director 01/02/2023
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Nomination de Mr Derek Anthony Howell en tant qu'administrateur le 01 févr. 2023

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Peter Dando en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward Michael Bashforth en tant que directeur le 01 févr. 2023

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Francesca Appleby en tant que secrétaire le 22 août 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 15 août 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 16 août 2020

    5 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 24 août 2020 au 11 août 2020

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 18 août 2019

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 août 2018

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 19 août 2017

    4 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de ENRICHTECH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HOWELL, Derek Anthony
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    Administrateur
    Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    One
    England
    United KingdomBritishDirector299032280001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627760001
    CLARKE, Emma Lynne
    5 River Avenue
    KT7 0RS Thames Ditton
    Surrey
    Secrétaire
    5 River Avenue
    KT7 0RS Thames Ditton
    Surrey
    British69597880001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488200001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director23098320003
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton-On-Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Secrétaire
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    BritishAccountant51167890002
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161623810001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector141395280001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector55975990001
    HORROCKS, Madeleine Victoria
    Flat 1
    245 Stoke Newington Church Street
    N16 9HP London
    Administrateur
    Flat 1
    245 Stoke Newington Church Street
    N16 9HP London
    BritishTrainee Solicitor71016710001
    KENNEDY, Samual Edward
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    Administrateur
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive Officer149343140001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    BritishCompany Director23098320003
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector63043630002
    SNOOK, David Philip
    The Manor House
    Burnett
    BS31 2TF Keynsham
    Administrateur
    The Manor House
    Burnett
    BS31 2TF Keynsham
    United KingdomBritishExecutive86850310001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Administrateur
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    United KingdomBritishAccountant51167890002
    THORLEY, Giles Alexander
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81928120002
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector128819260001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ENRICHTECH LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement5360893
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement4028125
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    ENRICHTECH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    First ranking fixed and floating security document
    Créé le 08 déc. 2006
    Livré le 18 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transactions
    • 18 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 mars 2005
    Livré le 01 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 01 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 mai 2003
    Livré le 09 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transactions
    • 09 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed supplemental to a composite guarantee and debenture dated 7TH august 2000
    Créé le 18 août 2000
    Livré le 21 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and obligations and liabilities due owing or incurred to the chargee (on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the secured documents) and to the finance parties by it or any other chargor under the secured documents (as defined)
    Brèves mentions
    As described in the composite guarantee and debenture save that the title for site no 48 in the table for freehold properties shall be deleted and replaced with CH445871 and CH432365 and the title for site no 34 in the table for l/h properties shall be deleted and replaced with GM781708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 07 août 2000
    Livré le 21 août 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the royal bank of scotland PLC (as security trustee on behalf of itself and the banks and the financial institutions from time to time parties to the secured documents) under or pursuant to the secured documents (as defined) as the same may be amended,varied,novated,supplemented or replaced and this debenture
    Brèves mentions
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 août 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ENRICHTECH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2023Commencement of winding up
    21 mars 2023Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    David Matthew Hammond
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    1 Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Emma Cray
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    practitioner
    One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0