EGS GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEGS GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04006942
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication
    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication
    • Traitement de données, hébergement et activités connexes (63110) / Information et communication
    • Portails Web (63120) / Information et communication

    Où se situe EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EGS GROUP LIMITED19 nov. 200819 nov. 2008
    E-GOVERNMENT SOLUTIONS LIMITED11 sept. 200011 sept. 2000
    PRECIS (1908) LIMITED02 juin 200002 juin 2000

    Quels sont les derniers comptes de EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2021

    10 pagesAA

    Satisfaction de la charge 040069420012 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 juil. 2020

    12 pagesAA

    Cessation de la nomination de Sean Anthony Mcdonough en tant que directeur le 30 sept. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2019

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 040069420012

    1 pagesMR05

    Nomination de Mr Richard Gareth Hughes en tant qu'administrateur le 20 mai 2019

    2 pagesAP01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 avr. 2019

    • Capital: GBP 1.00
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2018

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de George Hampton Wall, Jr en tant que directeur le 09 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Modification des détails de Proactis Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 juil. 2018

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 15 mars 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2017

    16 pagesAA

    État du capital au 29 déc. 2017

    • Capital: GBP 461,678.80
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Qui sont les dirigeants de EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SYKES, Timothy James
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    185151500001
    HUGHES, Richard Gareth
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    Administrateur
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinance Director259234800001
    SYKES, Timothy James
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant134824900001
    BISHOP, Robert Ludo James
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    Secrétaire
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    CanadianSolicitor71964950001
    CRAGNOLINI, Adriano
    Flat 12
    8 Penywern Road
    SW5 9ST London
    Secrétaire
    Flat 12
    8 Penywern Road
    SW5 9ST London
    Australian86619610002
    DEARY, Brendan Francis
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Secrétaire
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    161233030001
    DONNELLY, Thomas Patrick
    10 Anerley House
    20 Princes Square
    W2 4NP London
    Secrétaire
    10 Anerley House
    20 Princes Square
    W2 4NP London
    British81215910001
    ENRIGHT, Michael John
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    Secrétaire
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    BritishDirector73670210003
    GREEN, Peter David Andrew
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Secrétaire
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    British139608500001
    JONES, Howard Jeffrey
    31 Downs Court Road
    CR8 1BF Purley
    Surrey
    Secrétaire
    31 Downs Court Road
    CR8 1BF Purley
    Surrey
    BritishFinancial Controller123226640001
    KELLY, Martyn Paul
    3 Meadow Close
    TN13 3HZ Sevenoaks
    Kent
    Secrétaire
    3 Meadow Close
    TN13 3HZ Sevenoaks
    Kent
    British29274620001
    MITCHELL, Jamie Matthew
    510 Royle Building
    Wenlock Road
    N1 7SH London
    Secrétaire
    510 Royle Building
    Wenlock Road
    N1 7SH London
    British65275190003
    TOMA, Elena
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Secrétaire
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    172869130001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Secrétaire désigné
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BISHOP, Robert Ludo James
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    Administrateur
    22 Mount Road
    SW19 8ET London
    CanadianSolicitor71964950001
    BRADLEY JR, William
    PO BOX 8655
    Jackson
    Wyoming 83002
    United States
    Administrateur
    PO BOX 8655
    Jackson
    Wyoming 83002
    United States
    AmericanGeneral Counsel72426740002
    BUSBY, Ian Christopher
    40 Latimer Road
    Headington
    OX3 7PF Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    40 Latimer Road
    Headington
    OX3 7PF Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishExecutive77686270002
    DAVID, Julian Christopher
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Administrateur
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    EnglandBritishCompany Director73504660001
    ELLIS, Jeremy Colin Dupont
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Administrateur
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    United KingdomBritishCompany Director87784750002
    ENRIGHT, Michael John
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    Administrateur
    30 Chepstow Place
    W2 4TA London
    United KingdomBritishDirector73670210003
    FRASER, Jeffery Scott
    PO BOX 1550
    Wilson
    Wyoming 83014
    America
    Administrateur
    PO BOX 1550
    Wilson
    Wyoming 83014
    America
    AmericanSales73082610001
    GIBSON, Adrian George
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Administrateur
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    EnglandBritishManaging Director176478730001
    JAMES, Sebastian Richard Edward Cuthbert, The Honourable
    16 West Halkin Street
    SW1X 8JL London
    Administrateur
    16 West Halkin Street
    SW1X 8JL London
    EnglandBritish,FrenchCompany Director71965030001
    JONES, Rodney Desmond
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United Kingdom
    WalesBritishChief Executive Officer82816570003
    LAWLER, Philip James
    The Manor House
    RG10 0PX Shurlock Row
    Berkshire
    Administrateur
    The Manor House
    RG10 0PX Shurlock Row
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director67927020002
    MATHUR, Piyush
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Administrateur
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    United KingdomIndianPrivate Equity Investment Manager130337570001
    MCDONOUGH, Sean Anthony
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    Administrateur
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector83191640003
    MITCHELL, Jamie Matthew
    510 Royle Building
    Wenlock Road
    N1 7SH London
    Administrateur
    510 Royle Building
    Wenlock Road
    N1 7SH London
    United KingdomBritishDirector65275190003
    PELLY, Christopher Dunn
    Via Minigera 14
    Montagnola
    6926
    Switzerland
    Administrateur
    Via Minigera 14
    Montagnola
    6926
    Switzerland
    SwizerlandBritishVenture Capitalist71196640003
    SPRAY, Nigel Richard
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Administrateur
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    United KingdomBritishVenture Capitalist133975800001
    STANDER III, Henricus Johannus
    150 East 72nd Street
    5c
    NY 10021 New York
    New York
    Usa
    Administrateur
    150 East 72nd Street
    5c
    NY 10021 New York
    New York
    Usa
    AmericanCompany Director72426850001
    TURNER, Derek
    The Bridge House
    Wappenshall
    TF6 6DE Telford
    Salop
    Administrateur
    The Bridge House
    Wappenshall
    TF6 6DE Telford
    Salop
    BritishCivil Engineer123514720001
    WALL JR, George Hampton
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    Administrateur
    Floor
    1 Riverview Court Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    2nd
    West Yorkshire
    United StatesAmericanDirector239423450001
    WHENT, Peter John
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    Administrateur
    Baird House
    15-17 St Cross Street
    EC1N 8UW London
    United KingdomBritishChief Executive131769110002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EGS GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Proactis Limited
    Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    Riverview Court
    England
    15 mars 2017
    Castle Gate
    LS22 6LE Wetherby
    Riverview Court
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementEngland And Wales
    Numéro d'enregistrement03182974
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    EGS GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 févr. 2014
    Livré le 26 févr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 26 févr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 sept. 2019L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 10 déc. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Paul Barry-Walsh
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 20 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Whent
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 26 janv. 2011
    Livré le 03 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Katherine Ellis
    Transactions
    • 03 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 17 févr. 2010
    Livré le 06 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £85,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cabris Consulting Limited
    Transactions
    • 06 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 févr. 2010
    Livré le 06 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £115,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jerry Ellis
    Transactions
    • 06 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 02 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 févr. 2010
    Livré le 06 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £26,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Whent
    Transactions
    • 06 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 mars 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 juin 2009
    Livré le 08 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Jerry Ellis
    Transactions
    • 08 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 août 2007
    Livré le 18 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bms Finance Ab Limited
    Transactions
    • 18 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 mai 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Trust debenture
    Créé le 10 août 2006
    Livré le 22 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Panmure Capital Partners Limited
    Transactions
    • 22 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 28 oct. 2004
    Livré le 16 nov. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 nov. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 05 juin 2002
    Livré le 08 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Third floor 5-7 singer street london EC2.
    Personnes ayant droit
    • Techpartners International Limited
    Transactions
    • 08 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 août 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0