CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD

CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04011964
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    • Éducation préprimaire (85100) / Enseignement

    Où se situe CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    Adresse du siège social
    2 Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    Northamptonshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TRYGONE MANAGEMENT LTD16 déc. 200516 déc. 2005
    DOLPHIN NURSERIES LIMITED14 mars 200114 mars 2001
    FIRST START CHILDRENS NURSERY LIMITED06 juin 200006 juin 2000

    Quels sont les derniers comptes de CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 26 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 janv. 2016

    État du capital au 26 janv. 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 déc. 2015

    État du capital au 17 déc. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 18 nov. 2015

    • Capital: GBP 100
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 03/11/2015
    RES13

    Cessation de la nomination de Mary Ann Tocio en tant que directeur le 01 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2015

    État du capital au 17 juin 2015

    • Capital: GBP 23,910.58
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    11 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juin 2014

    État du capital au 17 juin 2014

    • Capital: GBP 23,910.59
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * 2 Crown Way Rushden Northamptonshire NN10 6BS United Kingdom* le 15 août 2012

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mr Stephen Kramer en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Nomination de Mary Ann Tocio en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Stephen Dreier en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de David Lissy en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Elizabeth Boland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mary Tocio en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United Kingdom
    170446830001
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican70853820001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican170443250001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    United StatesAmerican218331690001
    BROSNAN, Paul
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Secrétaire
    Croom House
    IRISH Croom
    Co Limerick
    Ireland
    Irish102089360001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Secrétaire
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    British2462470003
    GAIN, Jonathan Mark
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    British47508930005
    HATHER, Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British68848420004
    HURRAN, Anthony Robert
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    Secrétaire
    10 St Marks Road
    Ealing
    W5 3JS London
    British104970440001
    KRAMER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    British169896100001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Secrétaire
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    British134350220001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Administrateur
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLAND, Elizabeth
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican70853820001
    BROSNAN, Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomIrish102089360002
    CARNEY, Joseph Gerard
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    Administrateur
    272 Gunnersbury Avenue
    W4 5QB London
    Suite 2 Chiswick Place
    United KingdomIrish89273480001
    DHANANI, Alnur Madatali
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Administrateur
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    United KingdomBritish2462470003
    DHANANI, Yasmin Karim
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    Administrateur
    Simorgh
    Warren Road
    KT2 7HY Kingston
    Surrey
    United KingdomBritish15131290001
    DREIER, Stephen
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican170443250001
    HEMSLEY, Maarten Duncan
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    Administrateur
    265 Washington Street
    Duxbury
    Massachusetts 02332
    Usa
    United StatesBritish69602210003
    HURRAN, Anthony Robert
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    EnglandBritish184743670001
    LISSY, Dave
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    United StatesAmerican218331690001
    MOORE, Matthew Jon
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    Administrateur
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Suite 201
    United Kingdom
    United KingdomBritish115340530001
    PACE, Martin
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    Administrateur
    Christmas Farm
    Picketts Lane
    RH1 5RG Salfords
    Surrey
    EnglandBritish74305820001
    TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Kawartha Lodge Oak Grange Road
    West Clandon
    GU4 7UD Guildford
    Surrey
    United KingdomAustrian11820520001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    UsaUsa177507090001
    TOCIO, Mary Ann
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    Administrateur
    Crown Court
    NN10 6BS Rushden
    2
    Northamptonshire
    Uk
    UsaUsa177507090001

    CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A keyman insurance assignment
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from the company (the "assignor") to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company's interest in and to the policies and the proceeds and full benefit thereof; £500,000 over the life of martin charles pace,policy dated 24/8/2004,policy no X70585488. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,the Security Trustee
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2004
    Livré le 06 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,the Security Trustee
    Transactions
    • 06 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 30 juin 2000
    Livré le 13 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture and the loan stock deed of even date defined therein
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Development Vct PLC(As Security Trustee and Lender)
    Transactions
    • 13 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0