CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04011964 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?
| Adresse du siège social | 2 Crown Court NN10 6BS Rushden Northamptonshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2014 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?
| Bilan annuel |
|
|---|
Quels sont les derniers dépôts pour CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 18 nov. 2015
| 4 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mary Ann Tocio en tant que directeur le 01 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 11 pages | AA | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 11 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 10 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * 2 Crown Way Rushden Northamptonshire NN10 6BS United Kingdom* le 15 août 2012 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 11 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 06 juin 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Stephen Kramer en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||||||
Nomination de Mary Ann Tocio en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Stephen Dreier en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de David Lissy en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Nomination de Elizabeth Boland en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mary Tocio en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRAMER, Stephen | Secrétaire | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire United Kingdom | 170446830001 | |||||||
| BOLAND, Elizabeth | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 70853820001 | |||||
| DREIER, Stephen | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 170443250001 | |||||
| LISSY, Dave | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | United States | American | 218331690001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Secrétaire | Croom House IRISH Croom Co Limerick Ireland | Irish | 102089360001 | ||||||
| DHANANI, Alnur Madatali | Secrétaire | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | British | 2462470003 | ||||||
| GAIN, Jonathan Mark | Secrétaire | 9 Nash Place HP10 8ES Penn Buckinghamshire | British | 47508930005 | ||||||
| HATHER, Jon | Secrétaire | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||
| HURRAN, Anthony Robert | Secrétaire | 10 St Marks Road Ealing W5 3JS London | British | 104970440001 | ||||||
| KRAMER, Stephen | Secrétaire | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | British | 169896100001 | ||||||
| MOORE, Matthew Jon | Secrétaire | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 134350220001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BETTUM, Ole | Administrateur | 54 Primrose Gardens NW3 4TP London | England | Norwegian | 50551730002 | |||||
| BOLAND, Elizabeth | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 70853820001 | |||||
| BROSNAN, Paul | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | Irish | 102089360002 | |||||
| CARNEY, Joseph Gerard | Administrateur | 272 Gunnersbury Avenue W4 5QB London Suite 2 Chiswick Place | United Kingdom | Irish | 89273480001 | |||||
| DHANANI, Alnur Madatali | Administrateur | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | United Kingdom | British | 2462470003 | |||||
| DHANANI, Yasmin Karim | Administrateur | Simorgh Warren Road KT2 7HY Kingston Surrey | United Kingdom | British | 15131290001 | |||||
| DREIER, Stephen | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 170443250001 | |||||
| HEMSLEY, Maarten Duncan | Administrateur | 265 Washington Street Duxbury Massachusetts 02332 Usa | United States | British | 69602210003 | |||||
| HURRAN, Anthony Robert | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | England | British | 184743670001 | |||||
| LISSY, Dave | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | United States | American | 218331690001 | |||||
| MOORE, Matthew Jon | Administrateur | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 115340530001 | |||||
| PACE, Martin | Administrateur | Christmas Farm Picketts Lane RH1 5RG Salfords Surrey | England | British | 74305820001 | |||||
| TERNOFSKY, Friedrich Ludwig Rudolf | Administrateur | Kawartha Lodge Oak Grange Road West Clandon GU4 7UD Guildford Surrey | United Kingdom | Austrian | 11820520001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire | Usa | Usa | 177507090001 | |||||
| TOCIO, Mary Ann | Administrateur | Crown Court NN10 6BS Rushden 2 Northamptonshire Uk | Usa | Usa | 177507090001 |
CASTERBRIDGE CARE AND EDUCATION LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A keyman insurance assignment | Créé le 21 déc. 2004 Livré le 06 janv. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All obligations and liabilities due or to become due from the company (the "assignor") to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The company's interest in and to the policies and the proceeds and full benefit thereof; £500,000 over the life of martin charles pace,policy dated 24/8/2004,policy no X70585488. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 déc. 2004 Livré le 06 janv. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys and liabilities due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 juin 2000 Livré le 13 juil. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture and the loan stock deed of even date defined therein | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0