REDLANDS REAL ESTATES LIMITED

REDLANDS REAL ESTATES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéREDLANDS REAL ESTATES LIMITED
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04014985
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    309 Bury New Road
    M7 2YN Salford
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BERKELEY FIFTEEN LIMITED14 juin 200014 juin 2000

    Quels sont les derniers comptes de REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le29 sept. 2024
    Date d'échéance des prochains comptes29 juin 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2023

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juin 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation28 juin 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au14 juin 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2023

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Notification de Brooking Investments Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 juin 2023

    1 pagesPSC03

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2022

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor Cloisters House, Riverside New Bailey Street Manchester M3 5FS England à 309 Bury New Road Salford M7 2YN le 01 juin 2022

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2021

    10 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2020

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2019

    9 pagesAA

    Satisfaction de la charge 040149850006 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040149850008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040149850007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040149850009 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 040149850010 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 040149850012, créée le 18 juin 2019

    18 pagesMR01

    Inscription de la charge 040149850011, créée le 18 juin 2019

    18 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 14 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 040149850009, créée le 18 juin 2019

    18 pagesMR01

    Inscription de la charge 040149850010, créée le 18 juin 2019

    18 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2018

    9 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Bleier le 26 mars 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Mett le 26 mars 2019

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HENRY, Arnold
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    Secrétaire
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    BritishDirector10417920001
    BLEIER, Benjamin
    Humber Road
    NW2 6EW London
    Unit 3 Edge Business Centre
    England
    Administrateur
    Humber Road
    NW2 6EW London
    Unit 3 Edge Business Centre
    England
    EnglandBritishProperty Manager176226750001
    HENRY, Arnold
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    Administrateur
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    EnglandBritishDirector10417920001
    METT, Ian
    Humber Road
    NW2 6EW London
    Unit 3 Edge Business Centre
    England
    Administrateur
    Humber Road
    NW2 6EW London
    Unit 3 Edge Business Centre
    England
    EnglandBritishFinance126501020017
    NEUMANN, Henry
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    Administrateur
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    EnglandBritishDirector3677780001
    BROOKES, David
    Home Farm 37 Church Street
    Cotton In The Elms
    DE12 7PY Swadlincote
    Derbyshire
    Secrétaire
    Home Farm 37 Church Street
    Cotton In The Elms
    DE12 7PY Swadlincote
    Derbyshire
    British125937580001
    PUTTERGILL, Claire
    49 Pine Gardens
    KT5 8LJ Surbiton
    Surrey
    Secrétaire
    49 Pine Gardens
    KT5 8LJ Surbiton
    Surrey
    British49527970005
    BROOKES, David
    Home Farm 37 Church Street
    Cotton In The Elms
    DE12 7PY Swadlincote
    Derbyshire
    Administrateur
    Home Farm 37 Church Street
    Cotton In The Elms
    DE12 7PY Swadlincote
    Derbyshire
    EnglandBritishFinance Director125937580001
    FOSTER, Anthony Roy
    Walnut House
    Upper Basildon
    RG8 8LS Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Walnut House
    Upper Basildon
    RG8 8LS Reading
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector191938310001
    HUTCHINSON, Geoffrey
    Rectory Lodge
    Kyre
    WR15 8RW Tenbury Wells
    Worcestershire
    Administrateur
    Rectory Lodge
    Kyre
    WR15 8RW Tenbury Wells
    Worcestershire
    United KingdomBritishDirector16644000004
    LEWIS, Roger St John Hulton
    Le Bocage
    La Rue Du Bocage St Brelade
    JE3 8BP Jersey
    Channel Islands
    Administrateur
    Le Bocage
    La Rue Du Bocage St Brelade
    JE3 8BP Jersey
    Channel Islands
    Great BritainBritishDirector30879310004
    MARTIN, David Henry
    4 Holmes Close
    Sunninghill
    SL5 9TJ Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    4 Holmes Close
    Sunninghill
    SL5 9TJ Ascot
    Berkshire
    BritishDirector66912570001
    STARKEY, Richard Justin
    Moatside
    124 Browns Lane, Knowle
    B93 9BD Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    Moatside
    124 Browns Lane, Knowle
    B93 9BD Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishChartered Accountant122099810001
    WALKER, David John
    3 Maplewood
    Walmley
    B76 1JX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    3 Maplewood
    Walmley
    B76 1JX Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritishManaging Director61665280002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur REDLANDS REAL ESTATES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brooking Investments Limited
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    01 juin 2023
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleU.K. Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Mr Arnold Henry
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    14 juin 2017
    Bury New Road
    M7 2YN Salford
    309
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    REDLANDS REAL ESTATES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2019
    Livré le 27 juin 2019
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Handelsbanken PLC
    Transactions
    • 27 juin 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2019
    Livré le 27 juin 2019
    En cours
    Brève description
    The freehold land and buildings on the north side of redland hill, redland, bristol registered at hm land registry with title absolute under title number BL69430, the freehold land and buildings lying to the north of redland hill, redland, bristol registered at hm land registry with possessory title under title number BL69640 and the freehold property being hedley house, st nicholas avenue, gosforth NE3 1AJ registered at hm land registry with title absolute under title number TY337678.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Handelsbanken PLC
    Transactions
    • 27 juin 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2019
    Livré le 21 juin 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    The freehold land and buildings on the north side of redland hill, redland, bristol registered at hm land registry with title absolute under title number BL69430, the freehold land and buildings lying to the north of redland hill, redland, bristol registered at hm land registry with possessory title under title number BL69640 and the freehold property being hedley house, st nicholas avenue, gosforth NE3 1AJ registered at hm land registry with title absolute under title number TY337678.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Handelsbanken PLC
    Transactions
    • 21 juin 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 18 juin 2019
    Livré le 21 juin 2019
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Handelsbanken PLC
    Transactions
    • 21 juin 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 01 juil. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 avr. 2014
    Livré le 10 mai 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H st nicholas avenue, grove park, gosforth, newcastle t/no TY337678.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 mai 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 oct. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 avr. 2014
    Livré le 25 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Property known as the praedium charter walk redland bristol title numbers BL69430 and BL69640.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 25 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 oct. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 31 mars 2014
    Livré le 02 avr. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 02 avr. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 oct. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 21 févr. 2008
    Livré le 26 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a land and buildings lying to the north of redlands hill, redland, bristol t/no BL69640 and land and buildings on the north side of redlands hill, redland, bristol t/no BL69430 and all buildings, fixtures and fixed plant and machinery, the goodwill see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 26 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 15 oct. 2007
    Livré le 19 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at st nicolas avenue gosforth t/n TY337878, together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery.the benefit of all guarantees indemnities rent deposits.by way of assignment the goodwill of the business and all monies due in relation to contracts or policies of insurance.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 19 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment & charge
    Créé le 18 mars 2004
    Livré le 20 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Performance guarantees dated 30 october 2003 guarantor lloyds tsb bank PLC amount £538,083.00 no. GTYA030006631 and 28 november 2003 guarantor lloyds tsb bank PLC amount £341,983.00 no. GTYA030006861.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 20 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of rental assignment
    Créé le 18 mars 2004
    Livré le 20 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title benefit and interest of the company in and to all rent, licence fees or other sums received by the company from any tenant or licensee of the property (see form 395 for details). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 20 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 mars 2004
    Livré le 20 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bristol & West PLC
    Transactions
    • 20 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0