GREEN COMPLIANCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGREEN COMPLIANCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04022406
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GREEN COMPLIANCE LIMITED ?

    • Activités combinées de soutien aux installations (81100) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe GREEN COMPLIANCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    6 Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    Kent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GREEN COMPLIANCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GREEN COMPLIANCE PLC24 déc. 200924 déc. 2009
    GREEN CO2 PLC08 avr. 200908 avr. 2009
    WYATT GROUP PLC27 juin 200027 juin 2000

    Quels sont les derniers comptes de GREEN COMPLIANCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour GREEN COMPLIANCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 24 mai 2017

    • Capital: GBP 0.01
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 22/05/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard George Hodgson le 16 mai 2017

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr Michael Peter Thompson en tant qu'administrateur le 10 mai 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 juil. 2016

    État du capital au 19 juil. 2016

    • Capital: GBP 22,598,692.01
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP à 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR le 15 juin 2016

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 août 2015

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Roger Robinson en tant que directeur le 17 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée

    1 pagesCERT10

    Réenregistrement des statuts

    13 pagesMAR

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de réimmatriculation

    RES02

    Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée

    2 pagesRR02

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2015 au 31 août 2015

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Mark Roger Robinson en tant qu'administrateur le 05 août 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juil. 2015

    État du capital au 10 juil. 2015

    • Capital: GBP 22,598,692.01
    SH01

    Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP

    1 pagesAD04

    Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que directeur le 30 avr. 2015

    2 pagesTM01

    Nomination de Hugh Francis Edmonds en tant que secrétaire le 14 mai 2015

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de GREEN COMPLIANCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EDMONDS, Hugh Francis
    Riverside
    Medeay City Estate
    ME2 4DP Rochester
    47
    Kent
    Uk
    Secrétaire
    Riverside
    Medeay City Estate
    ME2 4DP Rochester
    47
    Kent
    Uk
    198361770001
    HODGSON, Richard George
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Administrateur
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    EnglandBritish155847280001
    THOMPSON, Michael Peter
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    Administrateur
    Stirling Park
    Laker Road
    ME1 3QR Rochester
    6
    Kent
    England
    EnglandBritish201529820001
    CHARLTON, John William Charles
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Rowan Lodge
    Gloucestershire
    British187391570001
    CURTIS, David Phillip
    School House
    Itchington Road, Tytherington
    GL12 8QE Wotton-Under-Edge
    Gloucestershire
    Secrétaire
    School House
    Itchington Road, Tytherington
    GL12 8QE Wotton-Under-Edge
    Gloucestershire
    British109635220002
    POMPHRETT, Reginald Benjamin
    14a Chapel Lane
    SS7 2PQ Hadleigh
    Essex
    Secrétaire
    14a Chapel Lane
    SS7 2PQ Hadleigh
    Essex
    British115655650001
    POMPHRETT, Reginald Benjamin
    14a Chapel Lane
    SS7 2PQ Hadleigh
    Essex
    Secrétaire
    14a Chapel Lane
    SS7 2PQ Hadleigh
    Essex
    British115655650001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Secrétaire désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED
    Mancunian House Norfolk Street
    M2 1DX Manchester
    Lancashire
    Secrétaire
    Mancunian House Norfolk Street
    M2 1DX Manchester
    Lancashire
    77050230001
    AYRE, Ian
    Paddock House
    Marton Court, Marton Cum Grafton
    YO51 9PY York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Paddock House
    Marton Court, Marton Cum Grafton
    YO51 9PY York
    North Yorkshire
    British66818490002
    BROWN, Edward Forrest
    TN22 3DT Fairwarp
    Cophall Farmhouse
    East Sussex
    England
    Administrateur
    TN22 3DT Fairwarp
    Cophall Farmhouse
    East Sussex
    England
    EnglandBritish112799410001
    CHARLTON, John William Charles
    Rowan Lodge Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Rowan Lodge Neata Farm
    Greet
    GL54 5BL Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish119598150002
    CURTIS, David Phillip
    School House
    Itchington Road, Tytherington
    GL12 8QE Wotton-Under-Edge
    Gloucestershire
    Administrateur
    School House
    Itchington Road, Tytherington
    GL12 8QE Wotton-Under-Edge
    Gloucestershire
    British109635220002
    HOLT, Robert
    Vincent Square
    SW1P 2NU London
    Flat 3 68
    England
    Administrateur
    Vincent Square
    SW1P 2NU London
    Flat 3 68
    England
    United KingdomBritish116572980002
    LACEY, Kevin Paul
    Magdalene Road
    TW17 0QN Shepperton
    10
    Middlesex
    Administrateur
    Magdalene Road
    TW17 0QN Shepperton
    10
    Middlesex
    United KingdomBritish135265880001
    POMPHRETT, Reginald Benjamin
    14a Chapel Lane
    SS7 2PQ Hadleigh
    Essex
    Administrateur
    14a Chapel Lane
    SS7 2PQ Hadleigh
    Essex
    EnglandBritish115655650001
    PROWSE, John
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    Administrateur
    Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    317
    Essex
    EnglandBritish96786510001
    ROBERTSON, David John
    The Malthouse
    Stanton Prior
    BA2 9HX Bath
    Administrateur
    The Malthouse
    Stanton Prior
    BA2 9HX Bath
    British54088010002
    ROBINSON, Mark Roger
    Riverside
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    47
    Kent
    Administrateur
    Riverside
    Medway City Estate
    ME2 4DP Rochester
    47
    Kent
    United KingdomBritish88218430001
    RUMMELS, Ian Richard
    34 New Street
    Charfield
    GL12 8ES Wotton-Under-Edge
    Hill View House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    Administrateur
    34 New Street
    Charfield
    GL12 8ES Wotton-Under-Edge
    Hill View House
    Gloucestershire
    United Kingdom
    United KingdomBritish80412680003
    RUSSELL, Andrew Nicholas
    Plymouth Copse
    Caerwys Road Babell
    CH8 8PZ Holywell
    Flintshire
    Administrateur
    Plymouth Copse
    Caerwys Road Babell
    CH8 8PZ Holywell
    Flintshire
    United KingdomBritish91395820001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Administrateur désigné
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Administrateur
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    54676560001
    WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED
    Mancunian House Norfolk Street
    M2 1DX Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    Mancunian House Norfolk Street
    M2 1DX Manchester
    Lancashire
    77050230001
    WACKS CALLER LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Administrateur
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    58396030003

    GREEN COMPLIANCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 27 nov. 2013
    Livré le 27 nov. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Abn Amro Commercial Finance PLC
    Transactions
    • 27 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 oct. 2013
    Livré le 31 oct. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rockridge Investments S.A.
    Transactions
    • 31 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 16 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 18 août 2011
    Livré le 25 août 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum standing to the credit of a deposit account. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Signal Property Investments LLP
    Transactions
    • 25 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2010
    Livré le 12 mai 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 12 mai 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 oct. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge over credit balances by a chargor for own liabilities
    Créé le 24 déc. 2009
    Livré le 09 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly k/a green CO2 PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any or all of the money or interest see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 30 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 09 avr. 2009
    Livré le 29 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession and charge
    Créé le 13 juin 2006
    Livré le 22 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 nov. 2002
    Livré le 18 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 18 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0