GREEN COMPLIANCE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GREEN COMPLIANCE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04022406 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GREEN COMPLIANCE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 6 Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester Kent England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GREEN COMPLIANCE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 août 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour GREEN COMPLIANCE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 24 mai 2017
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Richard George Hodgson le 16 mai 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Michael Peter Thompson en tant qu'administrateur le 10 mai 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP à 6 Stirling Park Laker Road Rochester Kent ME1 3QR le 15 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 août 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Roger Robinson en tant que directeur le 17 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Certificat de réimmatriculation de société anonyme à responsabilité limitée | 1 pages | CERT10 | ||||||||||||||
Réenregistrement des statuts | 13 pages | MAR | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Re-enregistrement d'une société publique en société à responsabilité limitée privée | 2 pages | RR02 | ||||||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2015 au 31 août 2015 | 1 pages | AA01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Mark Roger Robinson en tant qu'administrateur le 05 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 27 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 11 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Les registres ont été transférés à l'adresse du siège social enregistré 47 Riverside Medway City Estate Rochester Kent ME2 4DP | 1 pages | AD04 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de John William Charles Charlton en tant que directeur le 30 avr. 2015 | 2 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Hugh Francis Edmonds en tant que secrétaire le 14 mai 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de GREEN COMPLIANCE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDMONDS, Hugh Francis | Secrétaire | Riverside Medeay City Estate ME2 4DP Rochester 47 Kent Uk | 198361770001 | |||||||
| HODGSON, Richard George | Administrateur | Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | England | British | 155847280001 | |||||
| THOMPSON, Michael Peter | Administrateur | Stirling Park Laker Road ME1 3QR Rochester 6 Kent England | England | British | 201529820001 | |||||
| CHARLTON, John William Charles | Secrétaire | Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Rowan Lodge Gloucestershire | British | 187391570001 | ||||||
| CURTIS, David Phillip | Secrétaire | School House Itchington Road, Tytherington GL12 8QE Wotton-Under-Edge Gloucestershire | British | 109635220002 | ||||||
| POMPHRETT, Reginald Benjamin | Secrétaire | 14a Chapel Lane SS7 2PQ Hadleigh Essex | British | 115655650001 | ||||||
| POMPHRETT, Reginald Benjamin | Secrétaire | 14a Chapel Lane SS7 2PQ Hadleigh Essex | British | 115655650001 | ||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Secrétaire désigné | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017270001 | |||||||
| WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED | Secrétaire | Mancunian House Norfolk Street M2 1DX Manchester Lancashire | 77050230001 | |||||||
| AYRE, Ian | Administrateur | Paddock House Marton Court, Marton Cum Grafton YO51 9PY York North Yorkshire | British | 66818490002 | ||||||
| BROWN, Edward Forrest | Administrateur | TN22 3DT Fairwarp Cophall Farmhouse East Sussex England | England | British | 112799410001 | |||||
| CHARLTON, John William Charles | Administrateur | Rowan Lodge Neata Farm Greet GL54 5BL Cheltenham Gloucestershire | England | British | 119598150002 | |||||
| CURTIS, David Phillip | Administrateur | School House Itchington Road, Tytherington GL12 8QE Wotton-Under-Edge Gloucestershire | British | 109635220002 | ||||||
| HOLT, Robert | Administrateur | Vincent Square SW1P 2NU London Flat 3 68 England | United Kingdom | British | 116572980002 | |||||
| LACEY, Kevin Paul | Administrateur | Magdalene Road TW17 0QN Shepperton 10 Middlesex | United Kingdom | British | 135265880001 | |||||
| POMPHRETT, Reginald Benjamin | Administrateur | 14a Chapel Lane SS7 2PQ Hadleigh Essex | England | British | 115655650001 | |||||
| PROWSE, John | Administrateur | Ongar Road CM15 9HP Brentwood 317 Essex | England | British | 96786510001 | |||||
| ROBERTSON, David John | Administrateur | The Malthouse Stanton Prior BA2 9HX Bath | British | 54088010002 | ||||||
| ROBINSON, Mark Roger | Administrateur | Riverside Medway City Estate ME2 4DP Rochester 47 Kent | United Kingdom | British | 88218430001 | |||||
| RUMMELS, Ian Richard | Administrateur | 34 New Street Charfield GL12 8ES Wotton-Under-Edge Hill View House Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | 80412680003 | |||||
| RUSSELL, Andrew Nicholas | Administrateur | Plymouth Copse Caerwys Road Babell CH8 8PZ Holywell Flintshire | United Kingdom | British | 91395820001 | |||||
| CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED | Administrateur désigné | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 900017260001 | |||||||
| SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED | Administrateur | 16 Churchill Way CF10 2DX Cardiff | 54676560001 | |||||||
| WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED | Administrateur | Mancunian House Norfolk Street M2 1DX Manchester Lancashire | 77050230001 | |||||||
| WACKS CALLER LIMITED | Administrateur | Wacks Caller Steam Packet House 76 Cross Street M2 4JU Manchester | 58396030003 |
GREEN COMPLIANCE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 27 nov. 2013 Livré le 27 nov. 2013 | En cours | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 23 oct. 2013 Livré le 31 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 18 août 2011 Livré le 25 août 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The sum standing to the credit of a deposit account. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 30 avr. 2010 Livré le 12 mai 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances by a chargor for own liabilities | Créé le 24 déc. 2009 Livré le 09 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company formerly k/a green CO2 PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Any or all of the money or interest see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 09 avr. 2009 Livré le 29 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of accession and charge | Créé le 13 juin 2006 Livré le 22 juin 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 01 nov. 2002 Livré le 18 nov. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociét és telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0