TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04026633 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Unit 1 Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2014 |
Quels sont les derniers dépôts pour TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Nomination de Victoria Anne Chandler en tant que secrétaire le 17 août 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Meirion Warwick-Saunders en tant que secrétaire le 05 août 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 04 juil. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 30 sept. 2015 au 29 sept. 2015 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Stanley Wright en tant que directeur le 27 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Mel David Taylor en tant qu'administrateur le 27 nov. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Alan Stanley Wright en tant qu'administrateur le 17 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Thierry Georges Bouzac en tant que directeur le 01 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Keith Christopher Gibbon en tant que directeur le 14 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Oliver Carl Archer en tant qu'administrateur le 26 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013 | 8 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Thierry Georges Bouzac en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Timothy en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 04 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012 | 8 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr David Keith Christopher Gibbon en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Fiona Tee en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANDLER, Victoria Anne | Secrétaire | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | 212446760001 | |||||||
| ARCHER, Oliver Carl | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 150218430001 | |||||
| TAYLOR, Mel David | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | English | 203242420001 | |||||
| ARNOLD, Richard Stewart | Secrétaire | Palmer Road SP2 7LX Salisbury 5 Wiltshire | British | 60617500004 | ||||||
| BETSALEL, Malka | Secrétaire | 57 Brent Park Road NW4 3HW London | British | 82171640001 | ||||||
| CHAPMAN, Robert Francis | Secrétaire | Rowan Cottage Main Street Gumley LE16 7RU Market Harborough Leicestershire | British | 189485200002 | ||||||
| MCDERMOTT, Thomas Paul | Secrétaire | Newitt Place SO16 7FA Southampton 33 Hampshire | British | 134045580002 | ||||||
| SADLER, Stephen | Secrétaire | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | 158482770001 | |||||||
| WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion | Secrétaire | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | 165681760001 | |||||||
| STERLING REGISTRARS LIMITED | Secrétaire | 100 Hibernia Road TW3 3RN Hounslow Middlesex | 39753340001 | |||||||
| ASPLIN, Robert Alexander | Administrateur | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | Uk | British | 149870270001 | |||||
| BINT, Rodney Alan | Administrateur | Rose Farm Green Lane LE12 7LU Seagrave Leicestershire | England | British | 122001450001 | |||||
| BOUZAC, Thierry Georges | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | French | 87674390003 | |||||
| CHANDLER, Colin, Sir | Administrateur | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | England | British | 164519170001 | |||||
| CHAPMAN, Robert Francis | Administrateur | Rowan Cottage Main Street Gumley LE16 7RU Market Harborough Leicestershire | England | British | 189485200002 | |||||
| GIBBON, David Keith Christopher | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 49959390002 | |||||
| O HARA, John William | Administrateur | 124 Bawder Road Rd2 Albany Auckland 1311 New Zealand | New Zealand | 104151820001 | ||||||
| REEVE, Christine Elizabeth | Administrateur | Hatch Warren Lane Hatch Warren RG22 4RA Basingstoke Paterson House Hatch Warren Farm Hampshire | United Kingdom | New Zealander | 71773150002 | |||||
| SADLER, Stephen Paul | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 90689640003 | |||||
| SMITH, Kenneth Ronald | Administrateur | Telconia Close Headley Down GU35 8ED Bordon 7 Hampshire | United Kingdom | British | 34793900002 | |||||
| TEE, Fiona | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 66385440005 | |||||
| TIMOTHY, Fiona Maria | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | England | British | 161343370001 | |||||
| WHEELER, Brian Robert | Administrateur | 247 Kawa Kawa Bay Road RD5 Papakura South Auckland New Zealand | British | 71773090001 | ||||||
| WRIGHT, Alan Stanley | Administrateur | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire | England | British | 83067060001 | |||||
| YORK, Graham | Administrateur | Glebe House Ashmore SP5 5AE Shaftsbury Wiltshire | England | English | 91383980001 | |||||
| INTERNATIONAL NOMINEES LIMITED | Administrateur | 100 Hibernia Road TW3 3RN Hounslow Middlesex | 43895830001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnico Group Holdings Ltd | 06 avr. 2016 | Beechwood, Lime Tree Way Chineham Business Park, Chineham RG24 8WA Basingstoke Unit 1 Hampshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
TOTAL HOSPITALITY SOLUTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 18 sept. 2012 Livré le 25 sept. 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 janv. 2008 Livré le 26 janv. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future, including uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery, bookdebts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 01 févr. 2005 Livré le 05 févr. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti £4,000 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Deposit of £4,000. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0