CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04033327 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 9 King Street EC2V 8EA London United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
État du capital au 21 déc. 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2021 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2020 | 21 pages | AA | ||||||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 13 juil. 2018 | 6 pages | RP04CS01 | ||||||||||
Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 13 juil. 2017 | 5 pages | RP04CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Castleton Technology Intermediate Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 sept. 2020 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 18 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 18 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 18 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires | 18 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires | 18 pages | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires | 18 pages | AR01 | ||||||||||
Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2021 au 31 déc. 2020 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , 9 King Street, London, EC2V 8EA, United Kingdom à 9 King Street London EC2V 8EA le 17 sept. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de , the Walbrook Building 25 Walbrook, London, EC4N 8AF, United Kingdom à 9 King Street London EC2V 8EA le 17 sept. 2020 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2020 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Haywood Trefor Chapman en tant que directeur le 16 juin 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Karenjeet Kaur Showker en tant que secrétaire le 16 juin 2020 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr John Adler Ensign en tant qu'administrateur le 04 juin 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENSIGN, John Adler | Administrateur | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | 270872360001 | |||||
| GHILANI, Patrick Joseph, Mr. | Administrateur | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | 238655330001 | |||||
| TELERMAN, Roman | Administrateur | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | United States | American | 238407950001 | |||||
| GRIFFITHS, Helen | Secrétaire | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | 246084940001 | |||||||
| HARROLD, Alan Henry | Secrétaire | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | British | 88772110001 | ||||||
| HAYES, Peter Andrew | Secrétaire | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | 162492770001 | |||||||
| HAYES, Peter Andrew | Secrétaire | 2 Somersby Crescent SL6 3YY Maidenhead Berkshire | British | 66610550002 | ||||||
| HEUVEL, Christopher Edward Francis Van Den | Secrétaire | 7 Hawkes Leap GU20 6JL Windlesham Surrey | British | 14296970001 | ||||||
| MYHILL, Paul Harvey | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 United Kingdom | 175306470001 | |||||||
| O'RORKE, Nicholas | Secrétaire | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | 149445420001 | |||||||
| SHOWKER, Karenjeet Kaur | Secrétaire | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | 260899760001 | |||||||
| YOUNG, Jenny Louise | Secrétaire | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 | 218645120001 | |||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire désigné | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 | |||||||
| BALAAM, Martin Anthony | Administrateur | The Laurels Coole Lane CW5 8AY Nantwich Cheshire | United Kingdom | British | 82233550001 | |||||
| BROWN, Ian Christopher | Administrateur | Fox Hollow Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | England | British | 75493580001 | |||||
| CHAPMAN, Haywood Trefor | Administrateur | 25 Walbrook EC4N 8AF London The Walbrook Building United Kingdom | United Kingdom | British | 193406100001 | |||||
| COVE, Graham Lawrence | Administrateur | 2 White House Close SG14 3TW Watton At Stone Hertfordshire | England | British | 45340010002 | |||||
| DREDGE, Spencer Neal | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 138270950001 | |||||
| HALLETT, Peter John | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 20621770002 | |||||
| HARROLD, Alan Henry | Administrateur | Cherry Tree House The Drive SL8 5RE Bourne End Buckinghamshire | England | British | 88772110001 | |||||
| PERKS, Timothy Howard | Administrateur | Bowdown Farmhouse Burys Bank Road Greenham RG19 8DA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 100207880001 | |||||
| WALSH, Andrew Jeffrey | Administrateur | 49 Cornes Close SO22 5DS Winchester Hampshire | British | 42933190003 | ||||||
| WEAVER, Anthony Charles | Administrateur | Cambridge Business Park, Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Newton House United Kingdom | United Kingdom | British | 153397180001 | |||||
| YAPP, Stephen | Administrateur | Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington OX5 3JA Kidlington Building B - Office 10 Oxfordshire United Kingdom | England | British | 42686850001 | |||||
| YOUNG, Jenny Louise | Administrateur | Fetter Lane EC4A 1BN London 100 | England | British | 200518800001 | |||||
| HILLGATE NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018840001 | |||||||
| HILLGATE SECRETARIAL LIMITED | Administrateur désigné | 7th Floor Hillgate House 26 Old Bailey EC4M 7HW London | 900018850001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castleton Technology Intermediate Holding Company Limited | 06 avr. 2016 | King Street EC2V 8EA London 9 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 26 févr. 2015 Livré le 05 mars 2015 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Group debenture | Créé le 21 juin 2012 Livré le 29 juin 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge over shares | Créé le 24 févr. 2009 Livré le 27 févr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 01 oct. 2006 Livré le 13 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 24 nov. 2005 Livré le 06 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed between (1) the company and telecom and (2) mountcashel PLC (as security trustee) | Créé le 26 juin 2001 Livré le 07 juil. 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All money and liabilities now or in the future due owing or incurred to the chargee or the agent by the company or telecom under the loan agreement or amounts owing to the security trustee under the charge | |
Brèves mentions The security assets to the security trustee by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0