CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED

CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04033327
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    9 King Street
    EC2V 8EA London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    REDSTONE GROUP HOLDINGS LIMITED06 févr. 200206 févr. 2002
    REDSTONE COMMUNICATIONS LIMITED 17 déc. 200117 déc. 2001
    REDSTONE GROUP HOLDINGS LIMITED 30 mars 200130 mars 2001
    HILLGATE (174) LIMITED13 juil. 200013 juil. 2000

    Quels sont les derniers comptes de CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    État du capital au 21 déc. 2021

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 08 juil. 2021 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    21 pagesAA

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 13 juil. 2018

    6 pagesRP04CS01

    Deuxième dépôt de la déclaration de confirmation datée du 13 juil. 2017

    5 pagesRP04CS01

    Modification des détails de Castleton Technology Intermediate Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 17 sept. 2020

    2 pagesPSC05

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    18 pagesAR01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2021 au 31 déc. 2020

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de , 9 King Street, London, EC2V 8EA, United Kingdom à 9 King Street London EC2V 8EA le 17 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de , the Walbrook Building 25 Walbrook, London, EC4N 8AF, United Kingdom à 9 King Street London EC2V 8EA le 17 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juil. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Haywood Trefor Chapman en tant que directeur le 16 juin 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Karenjeet Kaur Showker en tant que secrétaire le 16 juin 2020

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr John Adler Ensign en tant qu'administrateur le 04 juin 2020

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ENSIGN, John Adler
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Administrateur
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    United StatesAmerican270872360001
    GHILANI, Patrick Joseph, Mr.
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Administrateur
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    United StatesAmerican238655330001
    TELERMAN, Roman
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Administrateur
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    United StatesAmerican238407950001
    GRIFFITHS, Helen
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    246084940001
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    British88772110001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Secrétaire
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    162492770001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    HEUVEL, Christopher Edward Francis Van Den
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Secrétaire
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British14296970001
    MYHILL, Paul Harvey
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United Kingdom
    Secrétaire
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    United Kingdom
    175306470001
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    149445420001
    SHOWKER, Karenjeet Kaur
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    260899760001
    YOUNG, Jenny Louise
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Secrétaire
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    218645120001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Secrétaire désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Administrateur
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Administrateur
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish75493580001
    CHAPMAN, Haywood Trefor
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Walbrook
    EC4N 8AF London
    The Walbrook Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish193406100001
    COVE, Graham Lawrence
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    Administrateur
    2 White House Close
    SG14 3TW Watton At Stone
    Hertfordshire
    EnglandBritish45340010002
    DREDGE, Spencer Neal
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish138270950001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    HARROLD, Alan Henry
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Cherry Tree House
    The Drive
    SL8 5RE Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish88772110001
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish100207880001
    WALSH, Andrew Jeffrey
    49 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    49 Cornes Close
    SO22 5DS Winchester
    Hampshire
    British42933190003
    WEAVER, Anthony Charles
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Administrateur
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish42686850001
    YOUNG, Jenny Louise
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    Administrateur
    Fetter Lane
    EC4A 1BN London
    100
    EnglandBritish200518800001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Administrateur désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Administrateur désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Castleton Technology Intermediate Holding Company Limited
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    King Street
    EC2V 8EA London
    9
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, England And Wales
    Numéro d'enregistrement06517747
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    CASTLETON GROUP HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 26 févr. 2015
    Livré le 05 mars 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 05 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Group debenture
    Créé le 21 juin 2012
    Livré le 29 juin 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 24 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the charged securities, any related rights, dividends, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 01 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 nov. 2005
    Livré le 06 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 févr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed between (1) the company and telecom and (2) mountcashel PLC (as security trustee)
    Créé le 26 juin 2001
    Livré le 07 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities now or in the future due owing or incurred to the chargee or the agent by the company or telecom under the loan agreement or amounts owing to the security trustee under the charge
    Brèves mentions
    The security assets to the security trustee by way of first fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mountcashel PLC (As Security Trustee) and Its Successors and Assigns
    Transactions
    • 07 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0