ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04033332
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BROADOAKS VCT LIMITED28 sept. 200028 sept. 2000
    HILLGATE (181) LIMITED13 juil. 200013 juil. 2000

    Quels sont les derniers comptes de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Avis d'achèvement de l'accord volontaire

    6 pages1.4

    Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 17 août 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 juil. 2012

    État du capital au 17 juil. 2012

    • Capital: GBP 11,190
    SH01

    Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet

    4 pages1.1

    Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    27 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    legacy

    7 pagesMG01

    Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 13 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Enter agreements 14/05/2010
    RES13

    Comptes annuels établis au 27 sept. 2009

    24 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Andrew Smith le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination d'un administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    GAIN, Jonathan Mark
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    9 Nash Place
    HP10 8ES Penn
    Buckinghamshire
    British47508930005
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158304380001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Secrétaire
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    British174231320001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Secrétaire désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001
    BETTUM, Ole
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    Administrateur
    54 Primrose Gardens
    NW3 4TP London
    EnglandNorwegian50551730002
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Administrateur
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)British35427700001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Administrateur
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    FRYER, Martin
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    The Badgers
    Cats Lane
    CO10 2SF Sudbury
    Suffolk
    British72517560003
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Administrateur
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Administrateur
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    ROBINSON, Anthony Leake
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Rose Garden
    Orchehill Avenue
    SL9 8QE Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British48323880002
    ROGERS, Michael Greig
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    Administrateur
    1 Jenningsbury Court
    London Road
    SG13 7NS Hertford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish107156650001
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Administrateur
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Administrateur
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Administrateur
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Administrateur
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    HILLGATE NOMINEES LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Administrateur désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018840001
    HILLGATE SECRETARIAL LIMITED
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    Administrateur désigné
    7th Floor Hillgate House
    26 Old Bailey
    EC4M 7HW London
    900018850001

    ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental legal mortgage
    Créé le 06 mai 2011
    Livré le 20 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Broad oaks gaul road march t/no CB295973 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 20 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 29 févr. 2008
    Livré le 14 mars 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital buildings fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 juin 2007
    Livré le 19 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 19 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 2006
    Livré le 20 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 20 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 2005
    Livré le 15 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 sept. 2004
    Livré le 28 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 28 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2004
    Livré le 11 mai 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transactions
    • 11 mai 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2000
    Livré le 19 oct. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan stock deed whereby the company issued to the lender 14% secured stock loan
    Brèves mentions
    Land at gaul road march cambridgeshire. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Venture Capital Trust PLC
    Transactions
    • 19 oct. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    ACTIVE CARE PARTNERSHIPS (BROADOAKS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 juin 2012Date of meeting to approve CVA
    20 août 2012Date of completion or termination of CVA
    Corporate voluntary arrangement (CVA)
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Dixon Fleming
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds
    practitioner
    Kpmg Llp
    1 The Embankment
    LS1 4DW Neville Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0