DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04036009 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED ?
| Adresse du siège social | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Anne Colette Jacqueline Thonon en tant que directeur le 10 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew David Coulsen en tant que directeur le 10 oct. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 sept. 2017 au 31 mars 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 27 sept. 2017
| 3 pages | SH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2016 | 26 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 juin 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Notification de Dimension Data Holdings Plc en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016 | 1 pages | PSC02 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Ms Anne Colette Jacqueline Thonon le 29 août 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2015 | 30 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Paul Francis Cooper en tant qu'administrateur le 21 mars 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Calvin Paul Wesley Goom en tant que directeur le 21 mars 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2014 | 28 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2014 au 30 sept. 2014 | 3 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Francis Cooper en tant que secrétaire le 02 févr. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr Calvin Paul Wesley Goom en tant qu'administrateur le 02 févr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Clare Horner en tant que secrétaire le 02 févr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Murray Skakel en tant que directeur le 02 févr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 30 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER, Paul Francis | Secrétaire | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | 194607120001 | |||||||
| COOPER, Paul Francis | Administrateur | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | England | British | 206909290001 | |||||
| HORNER, Clare | Secrétaire | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | British | 81932840001 | ||||||
| MAJURY, Robert Andrew | Secrétaire | 24 Canterbury Road GU14 6NW Farnborough Hampshire | British | 72155340001 | ||||||
| PENTER, Nicholas Trevor | Secrétaire | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | British | 81327550001 | ||||||
| SKAKEL, Steven Murray | Secrétaire | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | British | 29806610004 | ||||||
| BLAKELAW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Harbour Court Compass Road North Harbour PO6 4ST Portsmouth Hampshire | 38915800008 | |||||||
| ANE, Jerome Philippe | Administrateur | Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Darwin House Staffordshire | France | French | 148831600001 | |||||
| BERTHELON, Jean Jacques | Administrateur | 59 Boulevard Beausejour FOREIGN Paris Paris 75116 France | French | 114410380001 | ||||||
| COULSEN, Andrew David | Administrateur | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Switzerland | British | 87390090003 | |||||
| DOWNIE, Ian Michael Stuart | Administrateur | Beech Hill Easton SO21 1ED Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 81327720001 | |||||
| GIBBS, Simon Spencer | Administrateur | Weedon Lodge Farm House East End HP22 4NJ Weedon Buckinghamshire | England | British | 90259420001 | |||||
| GOOM, Calvin Paul Wesley | Administrateur | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | 194584790001 | |||||
| KAYLOR, Donald Graham | Administrateur | 1 Styperson Way Poynton SK12 1UJ Stockport Cheshire | British | 73180690001 | ||||||
| LEWIS, David Andrew | Administrateur | 17 Mill Road CF14 0XA Cardiff | United Kingdom | British | 63310660001 | |||||
| MAJURY, Robert Andrew | Administrateur | 24 Canterbury Road GU14 6NW Farnborough Hampshire | England | British | 72155340001 | |||||
| PENTER, Nicholas Trevor | Administrateur | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | 81327550001 | |||||
| SALVAGE, James Lloyd | Administrateur | Lissom Shaw Rickmanhill Road CR5 3LA Chipstead Surrey | British | 50498550001 | ||||||
| SKAKEL, Steven Murray | Administrateur | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | England | British | 29806610004 | |||||
| THONON, Anne Colette Jacqueline | Administrateur | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Luxembourg | Belgian | 146053560002 | |||||
| WINN, David Charles | Administrateur | NL-1016 Ex Amsterdam Keizersgracht 302 1v | The Netherlands | Irish | 150733800001 | |||||
| BLAKELAW DIRECTOR SERVICES LIMITED | Administrateur | New Court 1 Barnes Wallis Road PO15 5UA Fareham Hampshire | 67781590002 | |||||||
| NEXTIRAONE EUROPE HOLDINGS BV | Administrateur | Laan Van's-Gravenmade 24 2495 Aj's Gravenhage Netherlands | 114409680001 | |||||||
| RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V. | Administrateur | Laan Van `S-Gravenmade 24 `S-Gravenhage 2495 Aj Netherlands | 117640790001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension Data Holdings Plc | 06 avr. 2016 | Waterfront Business Park Fleet Road GU51 3QT Fleet Dimension Data House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
DIMENSION DATA COMMUNICATIONS UK LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 24 avr. 2013 Livré le 01 mai 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 12 oct. 2007 Livré le 20 oct. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions A first fixed equitable charge over the deposit £306,315.45. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 22 déc. 2005 Livré le 29 déc. 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Rent deposit deed | Créé le 29 août 2002 Livré le 04 sept. 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First legal fixed charge over rent deposit of £164,590.00 and any interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Créé le 20 mars 2002 Livré le 27 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Barclays bank PLC re alcatel e-businessdistribution limited business premium account number 50126586. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0