B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéB MIDGLEY SEAFOODS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04036033
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ?

    • Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (10200) / Industries manufacturières

    Où se situe B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 juil. 2021

    6 pagesLIQ03

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    42 pages600

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kpmg Llp 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH à 1 st. Peters Square Manchester M2 3AE le 07 mai 2021

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW à 8 Princes Parade Liverpool L3 1QH le 05 août 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 10 juil. 2020

    LRESSP

    Cessation de English Seafoods Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mars 2020

    1 pagesPSC07

    Notification de Youngs Seafood Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 mars 2020

    2 pagesPSC02

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 30 mars 2020

    • Capital: GBP 200
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 18/03/2020
    RES13

    Cessation de la nomination de Jenny Nancy Loncaster en tant que directeur le 25 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Timothy Mark Busby en tant que directeur le 12 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2019 au 31 mars 2020

    1 pagesAA01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de PO Box 16 Wilkin Chapman Llp New Oxford House Town Hall Square Grimsby North East Lincolnshire DN31 1HE England à Karro Food Group Hugden Way Norton Grove Industrial Estate Norton Malton North Yorkshire YO17 9HG

    1 pagesAD02

    Nomination de Mr Michael Kamiel Jan Alfons Kestemont en tant qu'administrateur le 04 juil. 2019

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Wilkin Chapman Company Secretarial Services Limited en tant que secrétaire le 04 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Qui sont les dirigeants de B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESTEMONT, Michael Kamiel Jan Alfons
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    Administrateur
    St. Peters Square
    M2 3AE Manchester
    1
    United KingdomBelgian231792890001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Secrétaire
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    British1031110002
    MIDGLEY, Lisbeth Jane
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Secrétaire
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    British70971410001
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secrétaire
    Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement02249348
    75197930001
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire désigné
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BRITTON, Christopher Paul
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish127835580001
    BUSBY, Timothy Mark
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandEnglish169852920001
    CHEESEMAN, David Benjamin
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    Administrateur
    83 Newland Park
    HU5 2DR Hull
    EnglandBritish1031110002
    DEN HOLLANDER, Leendert Pieter
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandDutch166335910001
    EVANS, Thomas Jeffrey
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    Administrateur
    Tudor Lodge
    308 Beverley Road Anlaby
    HU10 7BG Hull
    EnglandBritish2183390002
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LOFTS, Malcolm Herbert
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish177239110001
    LONCASTER, Jenny Nancy
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205633180001
    MIDGLEY, Barry George
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    Administrateur
    64 Mill Road
    Swanland
    HU14 3PL North Ferriby
    North Humberside
    EnglandBritish38013830001
    MIDGLEY, Fraser
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    Administrateur
    16 Kenilworth Avenue
    HU5 4BH Hull
    British70971400002
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Administrateur
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    29 mars 2020
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    England
    Non
    Forme juridiqueYoungs Seafood Ltd
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3751665
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Oui
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleEngland & Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement02353338
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 01 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 01 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 sept. 2008
    Livré le 04 oct. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 04 oct. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale the Security Agent
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 25 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transactions
    • 25 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 17 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All material premises being l/h interest in land and buildings on the north east side of wassand street, kingston upon hull, together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transactions
    • 17 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security accession deed
    Créé le 30 juin 2004
    Livré le 10 juil. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee, both present and future by way of first legal mortgage the property specified in schedule 1 to the accession deed, together with all buildings and fixtures and all the subsidiary shares and investments specified in schedule 2 to the accession deed;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Securityagent)
    Transactions
    • 10 juil. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 mai 2003
    Livré le 15 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 23 mars 2001
    Livré le 03 avr. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 avr. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 oct. 2000
    Livré le 01 nov. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 01 nov. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 nov. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    B MIDGLEY SEAFOODS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juil. 2020Commencement of winding up
    13 janv. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas James Timpson
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Mark Jeremy Orton
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    practitioner
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0