HUMYNE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHUMYNE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04036104
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HUMYNE LIMITED ?

    • Clubs avec licence (56301) / Hébergement et restauration
    • Autres activités récréatives et de loisirs n.c.a. (93290) / Activités artistiques, de loisirs et de divertissement

    Où se situe HUMYNE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    229 Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HUMYNE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PAGESCHOOL LIMITED18 juil. 200018 juil. 2000

    Quels sont les derniers comptes de HUMYNE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour HUMYNE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes complets avec exemption totale modifiés jusqu'au 31 janv. 2020

    7 pagesAAMD

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2020

    8 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2019

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 juil. 2018 au 31 janv. 2019

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    2 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2017

    10 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 09 mars 2018

    2 pagesCH01

    Modification des détails de Mr Andrew Timothy Balman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mars 2018

    2 pagesPSC04

    Changement d'adresse du siège social de 105-107 Beverley Road Hull East Yorkshire HU3 1TS à 229 Spring Bank Hull HU3 1LR le 10 oct. 2017

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes modifiés avec exemption totale pour une petite société jusqu'au 31 juil. 2016

    7 pagesAAMD

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2016

    8 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 20 févr. 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 20 févr. 2017

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2015

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital31 juil. 2015

    État du capital au 31 juil. 2015

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 19 juin 2015

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2014

    8 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de HUMYNE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAYS, David
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Secrétaire
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    British71928480002
    BALMAN, Andrew Timothy
    Brigwood
    NE47 6EX Haydon Bridge
    Appletreewick
    England
    Administrateur
    Brigwood
    NE47 6EX Haydon Bridge
    Appletreewick
    England
    EnglandBritish139738340005
    MAYS, David
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Administrateur
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    EnglandBritish71928480002
    BALMAN, Andrew
    Rosemount
    Elm Bank Road
    NE41 8HT Wylam
    Northumberland
    Secrétaire
    Rosemount
    Elm Bank Road
    NE41 8HT Wylam
    Northumberland
    British60609250001
    JL NOMINEES TWO LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Secrétaire désigné
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007220001
    JL NOMINEES ONE LIMITED
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    Administrateur désigné
    1 Saville Chambers
    5 North Street
    NE1 8DF Newcastle Upon Tyne
    900007210001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUMYNE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Andrew Timothy Balman
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    18 juil. 2016
    Spring Bank
    HU3 1LR Hull
    229
    England
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HUMYNE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 26 janv. 2010
    Livré le 29 janv. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The wellington club, wellington lane, kingston upon hull t/n HS171063 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 26 nov. 2009
    Livré le 11 déc. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of debenture
    Créé le 22 sept. 2003
    Livré le 27 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    105-107 beverley road kingston upon hull HU3 1TS fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets prestn & future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Coors Brewers Limited
    Transactions
    • 27 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 04 juil. 2003
    Livré le 09 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a the welly club 105-107 beverley road hull HU3 1TS. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 09 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 mai 2003
    Livré le 24 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 24 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 24 mai 2001
    Livré le 31 mai 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a 105-107 beverley road hull (now k/a the wellington club) t/n HS171063. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 mars 2001
    Livré le 13 mars 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 août 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0