HUMYNE LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HUMYNE LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04036104 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HUMYNE LIMITED ?
| Adresse du siège social | 229 Spring Bank HU3 1LR Hull England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HUMYNE LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour HUMYNE LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation d'office | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes complets avec exemption totale modifiés jusqu'au 31 janv. 2020 | 7 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2020 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 janv. 2019 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 29 avr. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 juil. 2018 au 31 janv. 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 2 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 juil. 2017 | 10 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 09 mars 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des détails de Mr Andrew Timothy Balman en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mars 2018 | 2 pages | PSC04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 105-107 Beverley Road Hull East Yorkshire HU3 1TS à 229 Spring Bank Hull HU3 1LR le 10 oct. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes modifiés avec exemption totale pour une petite société jusqu'au 31 juil. 2016 | 7 pages | AAMD | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 20 févr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 20 févr. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2015 | 8 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 18 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Timothy Balman le 19 juin 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 juil. 2014 | 8 pages | AA | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HUMYNE LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYS, David | Secrétaire | Spring Bank HU3 1LR Hull 229 England | British | 71928480002 | ||||||
| BALMAN, Andrew Timothy | Administrateur | Brigwood NE47 6EX Haydon Bridge Appletreewick England | England | British | 139738340005 | |||||
| MAYS, David | Administrateur | Spring Bank HU3 1LR Hull 229 England | England | British | 71928480002 | |||||
| BALMAN, Andrew | Secrétaire | Rosemount Elm Bank Road NE41 8HT Wylam Northumberland | British | 60609250001 | ||||||
| JL NOMINEES TWO LIMITED | Secrétaire désigné | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
| JL NOMINEES ONE LIMITED | Administrateur désigné | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HUMYNE LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Andrew Timothy Balman | 18 juil. 2016 | Spring Bank HU3 1LR Hull 229 England | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||
Nature du contrôle
| |||
HUMYNE LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Créé le 26 janv. 2010 Livré le 29 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The wellington club, wellington lane, kingston upon hull t/n HS171063 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 26 nov. 2009 Livré le 11 déc. 2009 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of debenture | Créé le 22 sept. 2003 Livré le 27 sept. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions 105-107 beverley road kingston upon hull HU3 1TS fixed & floating charges over the undertaking & all property & assets prestn & future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 04 juil. 2003 Livré le 09 juil. 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The property k/a the welly club 105-107 beverley road hull HU3 1TS. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 15 mai 2003 Livré le 24 mai 2003 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 24 mai 2001 Livré le 31 mai 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions The f/h property k/a 105-107 beverley road hull (now k/a the wellington club) t/n HS171063. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Mortgage debenture | Créé le 05 mars 2001 Livré le 13 mars 2001 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0