DRAKEFIELD SERVICES LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | DRAKEFIELD SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04039729 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DRAKEFIELD SERVICES LIMITED ?
| Adresse du siège social | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DRAKEFIELD SERVICES LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 janv. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour DRAKEFIELD SERVICES LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2017 | 4 pages | AA | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Miss Marianne Neville en tant qu'administrateur le 03 juil. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Gillian Pritchard le 30 avr. 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert James Scott en tant que directeur le 30 avr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Gillian Pritchard en tant qu'administrateur le 30 avr. 2016 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Catherine Zawada le 21 janv. 2016 | 1 pages | CH03 | ||||||||||
Nomination de Mr Mark Falcon Millar en tant qu'administrateur le 30 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Huggins en tant que directeur le 30 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Catherine Zawada en tant que secrétaire le 05 août 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Taguma Ngondonga en tant que secrétaire le 05 août 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 09 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert James Scott le 20 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Mark Huggins en tant qu'administrateur le 15 déc. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Kenneth Boland en tant que directeur le 19 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 janv. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Robert James Scott le 08 août 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Robert James Scott le 02 févr. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de DRAKEFIELD SERVICES LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMOND, Catherine | Secrétaire | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | 200482220002 | |||||||
| MILLAR, Mark Falcon | Administrateur | Basing View Basingstoke RG21 4EA Hants Fanum House United Kingdom | England | British | 84701400002 | |||||
| NEVILLE, Marianne | Administrateur | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | England | British | 235099440001 | |||||
| PRITCHARD, Gillian Rosemary | Administrateur | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | England | British | 208086500001 | |||||
| BARRY, Michael Edward | Secrétaire | 19 Nightingale Close SS6 9GE Rayleigh Essex | British | 58848100002 | ||||||
| DAVIES, John | Secrétaire | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 115843280001 | ||||||
| GROVES, Adrian | Secrétaire | 37 Twinstead SS12 9QN Wickford | British | 99502640001 | ||||||
| HANNAH, Gregory John | Secrétaire | 2 Sprewell House Lytton Grove SW15 2EU London | British | 71150290001 | ||||||
| NGONDONGA, Taguma | Secrétaire | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 171613400001 | |||||||
| TROUSDALE, Carolyn | Secrétaire | 2 Oaktree Cottages Brick Hill GU24 8TG Chobham Surrey | British | 112546110001 | ||||||
| LMG SERVICES LIMITED | Secrétaire | 38-40 London Fruit Exchange Brushfield Street E1 6EU London | 51356760001 | |||||||
| WOLLASTONS NOMINEES LIMITED | Secrétaire | Brierly Place New London Road CM2 0AP Chelmsford Essex | 41473940001 | |||||||
| ANDREWS, Ciaran Antoine Bernard | Administrateur | 9 Walk House Close Cranfield MK43 0HY Bedford Bedfordshire | England | English | 41986880001 | |||||
| BARRY, Michael Edward | Administrateur | 2 Enbrook Park Sandgate CT20 3SE Folkestone Kent | British | 58848100003 | ||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Administrateur | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| DURLING, Richard Adrian | Administrateur | 88 Bedford Close Corney Reach W4 2UE Old Chiswick London | British | 60324100001 | ||||||
| GALBRAITH, Andrew | Administrateur | 24 Connaught Road TW11 0PS Teddington Middlesex | United Kingdom | British | 114396030001 | |||||
| GROVES, Adrian | Administrateur | 37 Twinstead SS12 9QN Wickford | British | 99502640001 | ||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Administrateur | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| HUGGINS, Mark | Administrateur | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | England | British | 140607390001 | |||||
| LAWRENCE, Andrew William John | Administrateur | 15 Restharrow Way St Marys Island ME4 3HS Chatham Maritime Kent | British | 96010330001 | ||||||
| MORTON, Arthur Leonard Robert | Administrateur | Carden House Park Estate La Route Des Genets St Brelade JE3 8EQ Jersey | Jersey | British | 1827570002 | |||||
| MOSS, John Leonard | Administrateur | 13 Freemans Close SL2 4ER Stoke Poges Berkshire | British | 116272080001 | ||||||
| SCOTT, Robert James | Administrateur | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | England | British | 104000820011 | |||||
| SINCLAIR, Kevin Morris | Administrateur | Kalafrana 12 Malvern Drive IG8 0JW Woodford Green Essex | England | British | 97071590001 | |||||
| STRONG, Andrew Jonathan Peter | Administrateur | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 68169450005 | |||||
| TAYLOR, Andrew James | Administrateur | 83a Norsey Road CM11 1BT Billericay Essex | United Kingdom | British | 116272010001 | |||||
| TAYLOR, Andrew James | Administrateur | 28 Lampern Crescent CM12 0FD Billericay Essex | British | 60324030002 | ||||||
| TAYLOR, Ian | Administrateur | 37 Twinstead Seadens Meadow SS12 9QN Wickford Essex | British | 74749340001 | ||||||
| YOUNG, John Robert Christian | Administrateur | 109 Streathbourne Road SW17 8RA London | British | 66857090004 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DRAKEFIELD SERVICES LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drakefield Group Limited | 06 avr. 2016 | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
DRAKEFIELD SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 23 janv. 2006 Livré le 31 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any group company to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 janv. 2006 Livré le 31 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti £1,750,000 and all other monies due or to become due from drakefield group limited or any subsidiary to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0