TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED

TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04050400
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CITRUSDALE LIMITED10 août 200010 août 2000

    Quels sont les derniers comptes de TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au29 avr. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2021

    10 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU le 27 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 janv. 2020

    LRESSP

    État du capital au 30 déc. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 09/12/2019
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 29 avr. 2018

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kirk Dyson Davis en tant que directeur le 31 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Richard Smothers en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 août 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 mai 2016

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 10 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Secrétaire
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    207524370001
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Administrateur
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    British67008750001
    JONES, Henry
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    180592870001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    RUDD, Susan Clare
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    172446200001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    181021590001
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    Secrétaire
    High Street
    Pavenham
    MK43 7NJ Bedford
    Walnut Barn
    Bedfordshire
    British135181230001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Lucy Jane
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164754670001
    BENNETT, Keith Norman
    Handley Wood Cottage
    Longwalls Lane
    DE56 2DU Belper
    Derbyshire
    Administrateur
    Handley Wood Cottage
    Longwalls Lane
    DE56 2DU Belper
    Derbyshire
    British6629880006
    CLARKE, Robert
    71 Arthur Road
    SW19 7DN London
    Administrateur
    71 Arthur Road
    SW19 7DN London
    British40894440004
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DAVIS, Kirk Dyson
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67008750001
    GALLAGHER, Patrick James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish205366190001
    GODWIN-BRATT, Robert James
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish170184800001
    JONES, Karen Elisabeth Dind
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    Administrateur
    Paddock House
    9 Spencer Park Wandsworth
    SW18 2SX London
    United KingdomBritish47793260007
    KEIGHTLEY SAWDON, Brian David
    12 Dower Park
    SL4 4BQ Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    12 Dower Park
    SL4 4BQ Windsor
    Berkshire
    British34704210001
    KELLY, Daryl Antony
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86246470001
    KING, Thomas Rupert
    Upper Maisonette 29 Campden Grove
    W8 4JQ London
    Administrateur
    Upper Maisonette 29 Campden Grove
    W8 4JQ London
    EnglandBritish55630790002
    LANGFORD, Jonathan Robert
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish135408140001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Administrateur désigné
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MARGERRISON, Russell John
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish170590800001
    MCCOSH, William
    Walnut House
    Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Walnut House
    Burgage Lane
    NG25 0ER Southwell
    Nottinghamshire
    EnglandBritish15819540001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Administrateur désigné
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    RIKLIN, Cornel Carl
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    Administrateur
    103 Barrow Gate Road
    Chiswick
    W4 4QS London
    EnglandSwiss78412270001
    SILLS, Jeffrey Alan
    11 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    Administrateur
    11 Heath Park Drive
    BR1 2WQ Bromley
    Kent
    EnglandBritish94775770001
    SMITH, Benedict James
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    Administrateur
    Flat 9
    62 Eccleston Square
    SW1V 1PH London
    United KingdomBritish75231110001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Spirit Acquisition Properties Limited
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    England
    06 avr. 2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompaines House
    Numéro d'enregistrement4459630
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security agreement
    Créé le 31 oct. 2003
    Livré le 12 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to each finance party under each finance document
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 12 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 déc. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of accession to a security agreement dated 28 february 2003
    Créé le 25 avr. 2003
    Livré le 14 mai 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from the obligor to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed security over freehold and leasehold property. By way of first fixed charge all present and future freehold and leasehold property and any rights under any other agreement or document which gives the company a right to occupy or use property wheresoever situate now or hereafter belonging to it. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P., as Agent and Trustee for the Beneficiaries
    Transactions
    • 14 mai 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 sept. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 03 sept. 2000
    Livré le 15 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the beneficiaries under or pursuant to the senior finance documents and the mezzanine finance documents on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Cibc World Markets PLC (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 15 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 janv. 2020Commencement of winding up
    18 avr. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    practitioner
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0