TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 04050400 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Resolve Advisory Limited 22 York Buildings WC2N 6JU London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 29 avr. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 11 pages | LIQ13 | ||||||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 janv. 2021 | 10 pages | LIQ03 | ||||||||||||||
Déclaration de solvabilité | 5 pages | LIQ01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT United Kingdom à Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU le 27 janv. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital au 30 déc. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 août 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 29 avr. 2018 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 août 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Kirk Dyson Davis en tant que directeur le 31 janv. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Richard Smothers en tant qu'administrateur le 31 janv. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2017 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 23 août 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 01 mai 2016 | 12 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 10 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Nomination de Lindsay Anne Keswick en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Claire Susan Stewart en tant que secrétaire le 25 avr. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Sunrise House Ninth Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 3JZ à Westgate Brewery Bury St Edmunds Suffolk IP33 1QT le 07 mars 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 22 août 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Robert Langford en tant que directeur le 26 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KESWICK, Lindsay Anne | Secrétaire | 22 York Buildings WC2N 6JU London Resolve Advisory Limited | 207524370001 | |||||||
| SMOTHERS, Richard | Administrateur | IP33 1QT Bury St Edmunds Westgate Brewery Suffolk United Kingdom | United Kingdom | British | 242658700001 | |||||
| FREEMAN, Charles Truscott | Secrétaire | 9 The Uplands AL5 2PG Harpenden Hertfordshire | British | 67008750001 | ||||||
| JONES, Henry | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 180592870001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Secrétaire | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 172446200001 | |||||||
| RUDD, Susan Clare | Secrétaire | 17 Thacker Drive WS13 6NS Lichfield Staffordshire | British | 81789210004 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | 181021590001 | |||||||
| STEWART, Claire Susan | Secrétaire | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| WALMSLEY, Derek Kerr | Secrétaire | High Street Pavenham MK43 7NJ Bedford Walnut Barn Bedfordshire | British | 135181230001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| BELL, Lucy Jane | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164754670001 | |||||
| BENNETT, Keith Norman | Administrateur | Handley Wood Cottage Longwalls Lane DE56 2DU Belper Derbyshire | British | 6629880006 | ||||||
| CLARKE, Robert | Administrateur | 71 Arthur Road SW19 7DN London | British | 40894440004 | ||||||
| DANDO, Stephen Peter | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DAVIS, Kirk Dyson | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158484730001 | |||||
| DUTTON, Philip | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| FREEMAN, Charles Truscott | Administrateur | 9 The Uplands AL5 2PG Harpenden Hertfordshire | England | British | 67008750001 | |||||
| GALLAGHER, Patrick James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 205366190001 | |||||
| GODWIN-BRATT, Robert James | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 170184800001 | |||||
| JONES, Karen Elisabeth Dind | Administrateur | Paddock House 9 Spencer Park Wandsworth SW18 2SX London | United Kingdom | British | 47793260007 | |||||
| KEIGHTLEY SAWDON, Brian David | Administrateur | 12 Dower Park SL4 4BQ Windsor Berkshire | British | 34704210001 | ||||||
| KELLY, Daryl Antony | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 86246470001 | |||||
| KING, Thomas Rupert | Administrateur | Upper Maisonette 29 Campden Grove W8 4JQ London | England | British | 55630790002 | |||||
| LANGFORD, Jonathan Robert | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 135408140001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Administrateur désigné | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MARGERRISON, Russell John | Administrateur | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | England | British | 170590800001 | |||||
| MCCOSH, William | Administrateur | Walnut House Burgage Lane NG25 0ER Southwell Nottinghamshire | England | British | 15819540001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Administrateur | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| PRESTON, Neil David | Administrateur | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Administrateur désigné | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| RIKLIN, Cornel Carl | Administrateur | 103 Barrow Gate Road Chiswick W4 4QS London | England | Swiss | 78412270001 | |||||
| SILLS, Jeffrey Alan | Administrateur | 11 Heath Park Drive BR1 2WQ Bromley Kent | England | British | 94775770001 | |||||
| SMITH, Benedict James | Administrateur | Flat 9 62 Eccleston Square SW1V 1PH London | United Kingdom | British | 75231110001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur TOM COBLEIGH HOLDINGS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Spirit Acquisition Properties Limited |