OXUS GOLD PLC.

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOXUS GOLD PLC.
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 04056219
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OXUS GOLD PLC. ?

    • Extraction d'autres minerais métalliques non ferreux (07290) / Exploitation de mines et carrières

    Où se situe OXUS GOLD PLC. ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OXUS GOLD PLC. ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OXUS MINING PLC08 juin 200108 juin 2001
    GOLSKI LIMITED01 déc. 200001 déc. 2000
    GOLSKI LIMITED01 déc. 200001 déc. 2000
    INTERCEDE 1642 LIMITED21 août 200021 août 2000

    Quels sont les derniers comptes de OXUS GOLD PLC. ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour OXUS GOLD PLC. ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    30 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    23 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    22 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    21 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 08 déc. 2016

    11 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    13 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Cessation de la nomination de Oliver Charles Prior en tant que directeur le 01 janv. 2017

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Richard Barry Shead en tant que directeur le 04 janv. 2017

    2 pagesTM01

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 26 juil. 2016

    10 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    7 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Prince Frederick House, 35-39 Maddox Street Maddox Street London W1S 2PP à 55 Baker Street London W1U 7EU le 09 févr. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    2 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de OXUS GOLD PLC. ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILKINS, Richard Vaughan Lindsay
    Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    The Cottage
    Middlesex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    The Cottage
    Middlesex
    United Kingdom
    150422970001
    CHANDHOK, Jyoti
    Southover
    Woodside Park
    N12 7ES London
    52
    Secrétaire
    Southover
    Woodside Park
    N12 7ES London
    52
    BritishAccountant136476060001
    KIPPS, Jonathan Arthur
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    Secrétaire
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    South African BritishFinance Director86182020001
    TAYLOR, Kenneth Dudley
    25 Belgrave Manor
    Brooklyn Road
    GU22 7TW Woking
    Surrey
    Secrétaire
    25 Belgrave Manor
    Brooklyn Road
    GU22 7TW Woking
    Surrey
    AustralianFinancial Officer73399270001
    WILKINS, Richard Vaughan Lindsay
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    Secrétaire
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    BritishAccountant47021800001
    MITRE SECRETARIES LIMITED
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    Secrétaire désigné
    Mitre House
    160 Aldersgate Street
    EC1A 4DD London
    900004680001
    BECKETT, Michael Ernest
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    Administrateur
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    BritishDirector118661100001
    COOPER, Charles Arthur
    360 N Wilton Road
    06840 New Canaan
    Connecticut
    Usa
    Administrateur
    360 N Wilton Road
    06840 New Canaan
    Connecticut
    Usa
    AmericanDirector48634460001
    DE VILLIERS, Michael John
    Lorien
    Elms Road
    RG27 9DX Hook
    Hampshire
    Administrateur
    Lorien
    Elms Road
    RG27 9DX Hook
    Hampshire
    EnglandBritishDirector72809180002
    DEASY, Patrick
    Flat B 47 Hartham Road
    N7 9JJ London
    Administrateur
    Flat B 47 Hartham Road
    N7 9JJ London
    BritishSolicitor61686750001
    DJALALOV, Miradil Sabitovich
    Sh. Islamov Street 26
    Tashkent
    100115
    Uzbekistan
    Administrateur
    Sh. Islamov Street 26
    Tashkent
    100115
    Uzbekistan
    UzbekDirector127492550001
    DONALD, John Clow
    21 The Boulevardes
    Patterson Lakes
    Melbourne
    3197
    Australia
    Administrateur
    21 The Boulevardes
    Patterson Lakes
    Melbourne
    3197
    Australia
    BritishDirector127376400001
    DONALD, John Clow
    6 Derby Court
    The Promenade
    IM9 1BG Castletown
    Isle Of Man
    Administrateur
    6 Derby Court
    The Promenade
    IM9 1BG Castletown
    Isle Of Man
    South African BritishCompany Director86487580001
    HILL, Graham David
    Audern Road
    DN16 3LH Scunthorpe
    19
    South Humberside
    Administrateur
    Audern Road
    DN16 3LH Scunthorpe
    19
    South Humberside
    BritishMining128201300001
    KAPPES, Daniel William
    1721 York Way
    Sparks
    Nevada
    89431
    Usa
    Administrateur
    1721 York Way
    Sparks
    Nevada
    89431
    Usa
    AmericanMining Engineer86805130001
    KIPPS, Jonathan Arthur
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    Administrateur
    18 Bowling Green Road
    IM9 1EB Castletown
    Isle Of Man
    South African BritishChartered Accountant86182020001
    MCBURNEY, James Ronald Gordon
    Luxemburg Gardens
    W6 7EA London
    4
    Administrateur
    Luxemburg Gardens
    W6 7EA London
    4
    United KingdomUk Usa Dual CitizenDirector136300730001
    MCLEAN SUTHERLAND, Douglas
    5 Great Snoring Road
    NR21 0PG Hindringham
    Norfolk
    Administrateur
    5 Great Snoring Road
    NR21 0PG Hindringham
    Norfolk
    BritishChartered Accountant101033050001
    NORTON, Darryl
    23 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane St Mary's Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    23 The Old Saw Mill
    Long Mill Lane St Mary's Platt
    TN15 8QJ Sevenoaks
    Kent
    BritishAlternate Director125664290001
    PAS, Guido Edward
    6 Chemin Du Mousseron
    Pregny-Chamesy
    Switzerland
    Administrateur
    6 Chemin Du Mousseron
    Pregny-Chamesy
    Switzerland
    BelgianFinancier97587960001
    PRIOR, Oliver Charles
    Full Moon Barn
    Warren Road
    TN35 4AN Fairlight
    East Sussex
    Administrateur
    Full Moon Barn
    Warren Road
    TN35 4AN Fairlight
    East Sussex
    Great BritainBritishConsultant127221690001
    RICH, Michael William
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    Administrateur désigné
    Hillfield
    Gorse Hill Farningham
    DA4 0JU Dartford
    Kent
    British900020860001
    SHEAD, Richard Barry
    Upper Berkeley Street
    W1H 5QJ London
    42
    United Kingdom
    Administrateur
    Upper Berkeley Street
    W1H 5QJ London
    42
    United Kingdom
    United KingdomSouth AfricanDirector131162590003
    SHEAD, Richard Barry
    5 Buckland Place
    Bedfordview
    Gauteng 2007
    South Africa
    Administrateur
    5 Buckland Place
    Bedfordview
    Gauteng 2007
    South Africa
    South AfricaDirector86349190001
    TREW, William James
    30a Arklow Road
    Bryanston
    Gauteng 2021
    South Africa
    Administrateur
    30a Arklow Road
    Bryanston
    Gauteng 2021
    South Africa
    South African/BritishCompany Director87018470001
    TURNER, Roger William
    45 Greenmeads
    Westfield
    GU22 9QJ Woking
    Surrey
    Administrateur
    45 Greenmeads
    Westfield
    GU22 9QJ Woking
    Surrey
    EnglandBritishChief Executive Officer11594180001
    WARNER, William
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    Administrateur désigné
    2 Honeysuckle Gardens
    CR0 8XU Croydon
    British900019540001
    WARRENDER, Anthony Michael
    Oak Ridge Farm
    PO BOX 1431
    IRISH Middleburg
    Virginia 20118
    Usa
    Administrateur
    Oak Ridge Farm
    PO BOX 1431
    IRISH Middleburg
    Virginia 20118
    Usa
    BritishFinance Consulting48401540002
    WELLESLEY-WOOD, Mark Michael
    Dolphin House
    Hayes Lane, Slinfold
    RH13 7SN Horsham
    West Sussex
    Administrateur
    Dolphin House
    Hayes Lane, Slinfold
    RH13 7SN Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishEngineer41874630004
    WILKINS, Richard Vaughan Lindsay
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    Administrateur
    The Cottage Old Rectory Lane
    Denham
    UB9 5AH Uxbridge
    Middlesex
    EnglandBritishAccountant47021800001
    WYLIE, Gordon Ferguson
    64 7th Avenue
    Melville
    Gauteng 2092
    South Africa
    Administrateur
    64 7th Avenue
    Melville
    Gauteng 2092
    South Africa
    BritishGeologist110835790001

    OXUS GOLD PLC. a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A mortgage over proceeds
    Créé le 26 juin 2012
    Livré le 05 juil. 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest from time to time in and to the proceeds (and all related rights) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gretton Limited
    Transactions
    • 05 juil. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Priorities agreement
    Créé le 27 févr. 2012
    Livré le 15 mars 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The proceeds. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gretton Limited
    Transactions
    • 15 mars 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2009
    Livré le 18 mars 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £126,750 from time to time currently held on account.
    Personnes ayant droit
    • Autonomy Systems Limited
    Transactions
    • 18 mars 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 févr. 2009
    Livré le 28 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first fixed equitable charge oto the landlord over the deposit balance given by the tenant with full title guarantee as continuing security for the secured liabilities. On the date of the rent deposit deed the tenant paid to the landlord £34,978 which was paid into the deposit account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Berkeley Square Holdings Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 25 févr. 2009
    Livré le 28 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    A first fixed equitable charge over the deposit balance. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Berkeley Square Holdings Limited
    Transactions
    • 28 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 10 nov. 2008
    Livré le 19 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon, the charged account being: barclays bank PLC re oxus gold PLC, euro business premium account, numbered 55401133.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 22 janv. 2007
    Livré le 25 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £37,235.26 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    All sums falling due pursuant to a lease. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbsi Custody Bank Limited and Rbsi Trust Company Limited Being the Trustees of the Hanoverproperty Unit Trust
    Transactions
    • 25 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 11 mai 2006
    Livré le 18 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £37,235.26 and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    All sums falling due pursuant to the lease dated 11TH may 2006. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbsi Custody Bank Limited and Rbsi Trust Company Limited Being the Trustees of the Hanoverproperty Unit Trust
    Transactions
    • 18 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over the oxus gold/oxus malta credit agreement
    Créé le 25 janv. 2006
    Livré le 03 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in each charged agreement being the oxus gold/oxus malta credit agreement,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedbank Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over the agf credit agreement
    Créé le 25 janv. 2006
    Livré le 03 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in each charged agreement being the agf credit agreement dated 17 july 2002 and amended and restated on 2 april 2003,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedbank Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 25 janv. 2006
    Livré le 03 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    With full title guarantee the securities being all shares listed in the charge including all dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nedbank Limited
    Transactions
    • 03 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over bank account
    Créé le 07 janv. 2005
    Livré le 14 janv. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The chargor hereby charges with full title guarantee the deposit;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (Trustee)
    Transactions
    • 14 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed
    Créé le 17 juin 2003
    Livré le 20 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The credit balance on the companies account at national westminster bank PLC (account number 41806492 sort code 01-00-08) including all monies to be paid into such account in accordance with the said deed.
    Personnes ayant droit
    • Haslemere Estates Public Limited
    Transactions
    • 20 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 17 juil. 2002
    Livré le 06 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge the securities (as defined therein). See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (As Trustee for the Secured Parties)
    Transactions
    • 06 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 19 janv. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)

    OXUS GOLD PLC. a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 janv. 2016Administration started
    04 janv. 2021Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Shane Crooks
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0