BAXI 2000 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBAXI 2000 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04059868
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BAXI 2000 LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe BAXI 2000 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BAXI 2000 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NEW BAXI HOLDINGS LIMITED24 nov. 200024 nov. 2000
    DELTAREPAIR LIMITED25 août 200025 août 2000

    Quels sont les derniers comptes de BAXI 2000 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour BAXI 2000 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 déc. 2012

    6 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 16 déc. 2011

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 12 déc. 2011

    • Capital: GBP 2
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium cancelled 09/12/2011
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Divers

    Auditors resignation sect 519 ca 2006
    2 pagesMISC

    Divers

    Auditors resignation sect 519 ca 2006
    2 pagesMISC

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Karen Roberts le 27 sept. 2010

    2 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Leslie Nash le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 28 sept. 2010

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England le 27 sept. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Robert Leslie Nash le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John Mcfaull le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Adrian Egerton Darling le 13 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de BAXI 2000 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director13813980005
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    BritishFinancial Controller83628430003
    NASH, Robert Leslie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritishFinancial Controller83397580001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Secrétaire
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Secrétaire
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    BritishChartered Accountant56562210001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Secrétaire
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    BritishChartered Accountant56562210001
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    PITMAN, David John
    131 Saint Asaph Road
    SE4 2DZ London
    Secrétaire
    131 Saint Asaph Road
    SE4 2DZ London
    British72343630001
    ROTHWELL, Peter Jeffrey
    7 Riefield
    Harpers Lane
    BL1 6TA Bolton
    Lancashire
    Secrétaire
    7 Riefield
    Harpers Lane
    BL1 6TA Bolton
    Lancashire
    British55070650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CLARK, Richie
    80e Compayne Gardens
    NW6 3RU London
    Administrateur
    80e Compayne Gardens
    NW6 3RU London
    CanadianSolicitor75854350002
    DAVIES, Michael Thomas
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    Administrateur
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    BritishDirector50770000002
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Administrateur
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant56562210001
    GRAY, Bryan Mark
    The Firs 69 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    The Firs 69 The Common
    Parbold
    WN8 7EA Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector34960210001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002

    BAXI 2000 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A guarantee and debenture
    Créé le 12 mars 2004
    Livré le 25 mars 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the charging companies to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Agent and Trustee (The Security Trustee) for the Securedparties
    Transactions
    • 25 mars 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Créé le 22 nov. 2000
    Livré le 08 déc. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company (formerly known as deltarepair limited) to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 08 déc. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BAXI 2000 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 juil. 2013Dissolved on
    16 déc. 2011Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0