OPAL TRAFFORD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOPAL TRAFFORD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04081343
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OPAL TRAFFORD LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe OPAL TRAFFORD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    GRANT THORNTON UK LLP
    4 Hardman Square Spinninfields
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de OPAL TRAFFORD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour OPAL TRAFFORD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 avr. 2017

    24 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 avr. 2016

    18 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 avr. 2015

    15 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:s/s cert, release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:court order - replacement of liquidator
    31 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 mars 2015

    19 pages4.68

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:order of court - replacement of liquidator
    36 pagesLIQ MISC OC

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 05 mars 2014

    19 pages2.24B

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 13 sept. 2013

    18 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    5 pages2.16B

    Résultat de la réunion des créanciers

    1 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    46 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * C/O Opal Property Group the Place Ducie Street Manchester M1 2TP* le 03 avr. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2012

    16 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2012

    État du capital au 12 nov. 2012

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OPAL TRAFFORD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MELLOR, Craig Allan
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    Secrétaire
    21 Queenston Road
    Didsbury
    M20 2NX Manchester
    British60906780002
    DUNCAN, Gavin Robert
    Hardman Square
    Spinninfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    Hardman Square
    Spinninfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish151512820001
    MELLOR, Craig Allan
    Hardman Square
    Spinninfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    Hardman Square
    Spinninfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish60906780002
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Secrétaire désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Administrateur désigné
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    OPAL TRAFFORD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 19 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies as the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/n GM683090 assigns the rental income, the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all agreements for lease and all sums payable to the company under or in respect of any agreement for lease the goodwill of the business floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time placed on or used in or about the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 19 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 juin 2003
    Livré le 19 juin 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any company which is a member of the same group of companies as the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts buiildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 19 juin 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 03 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold land at wilmslow road manchester title numbers LA20130, GM406139 and GM683090. The gross rents licence fees and other monies receivable now or hereafter at any time by the company in respect of or arising out of any lease of the property or any agreement for lease or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over building contract
    Créé le 03 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the benefit of the company's interest in a building contract in form jct 1998 with contractor's design dated 3 august 2001 together with any bond issued pursuant thereto. All rights, titles, benefits and interest of the company whatsoever present and/or future whether proprietary, contractual or otherwise arising out of or connected with or relating to such building contract and bond including without limitation all claims for damages in respect of any breach thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juil. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OPAL TRAFFORD LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 mars 2013Administration started
    05 mars 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    practitioner
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Leslie Ross
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    2
    DateType
    05 mars 2014Commencement of winding up
    24 juil. 2018Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Leslie Ross
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    Daniel Robert Whiteley Smith
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    practitioner
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    David Michael Riley
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    proposed liquidator
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Daniel Robert Whiteley Smith
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    proposed liquidator
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Leslie Ross
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester
    proposed liquidator
    Grant Thornton Uk Llp
    4 Hardman Square
    M3 3EB Spinningfields
    Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0