OBJECT GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOBJECT GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04083144
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OBJECT GROUP LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe OBJECT GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bde House
    Blackpole Trading Estate
    WR3 8ZP Worcester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OBJECT GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OBJECT SUPPORT LIMITED01 mars 200101 mars 2001
    OBJECT GROUP LIMITED03 oct. 200003 oct. 2000

    Quels sont les derniers comptes de OBJECT GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour OBJECT GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    legacy

    1 pages652a
    AFCIZCC6

    legacy

    1 pages288b
    XMRK1AX2

    legacy

    4 pages363a
    X171A4BV

    legacy

    1 pages190
    X17194BU

    legacy

    1 pages287
    X17174BS

    legacy

    1 pages353
    X17184BT

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2007

    3 pagesAA
    ABULP3D5

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363s

    legacy

    pages363(287)

    legacy

    pages363(353)

    legacy

    1 pages225

    legacy

    6 pages363s

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 oct. 2005

    7 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages403a

    legacy

    2 pages403a

    Qui sont les dirigeants de OBJECT GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LINNEY, John Charles
    4 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    Administrateur
    4 Lakeside Drive
    KT10 9EZ Esher
    Surrey
    GbBritishCompany Director73905400006
    EXLEY, Colin Peter
    48 Muncaster Road
    SW11 6NU Battersea
    London
    Secrétaire
    48 Muncaster Road
    SW11 6NU Battersea
    London
    BritishDirector48053650001
    LEFKON, Adam
    Flat 1 56 Thrale Road
    SW16 1NY London
    Secrétaire
    Flat 1 56 Thrale Road
    SW16 1NY London
    British79206150001
    MCRITCHIE, Ruth Elizabeth
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    Secrétaire
    9 Churchfarm Close
    BS37 5BZ Yate
    South Gloucestershire
    British101309030001
    WRIGHT, Peter Michael
    4 Wakeman Street
    WR3 8BQ Worcester
    Worcestershire
    Secrétaire
    4 Wakeman Street
    WR3 8BQ Worcester
    Worcestershire
    BritishF D8860020001
    MACLAY MURRAY & SPENS
    10 Foster Lane
    EC2V 6HH London
    Secrétaire
    10 Foster Lane
    EC2V 6HH London
    120008090001
    WSM SERVICES LIMITED
    Wsm Pinnacle House
    17-25 Hartfield Road Wimbledon
    SW19 3SE London
    Secrétaire
    Wsm Pinnacle House
    17-25 Hartfield Road Wimbledon
    SW19 3SE London
    30807900002
    CASSELL, Petrina
    83 Highlands Heath
    Portsmouth Road
    SW15 3TX London
    Administrateur
    83 Highlands Heath
    Portsmouth Road
    SW15 3TX London
    BritishCompany Formation Agent77019440003
    EXLEY, Colin Peter
    48 Muncaster Road
    SW11 6NU Battersea
    London
    Administrateur
    48 Muncaster Road
    SW11 6NU Battersea
    London
    BritishDirector48053650001

    OBJECT GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 déc. 2005
    Livré le 23 déc. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the noteholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Peter Reynolds and Christine Reynolds for Such Persons as are the Registered Owners of the Loannotes from Time to Time (The Noteholders)
    Transactions
    • 23 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 27 août 2004
    Livré le 15 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Peter and Christine Reynolds
    Transactions
    • 15 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 août 2004
    Livré le 08 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Enterprise Finance Europe (UK) Limited
    Transactions
    • 08 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 août 2004
    Livré le 07 sept. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 07 sept. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 08 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £11,560 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The interest of the company in the deposit account and the balance standing from time to time therein.
    Personnes ayant droit
    • Marston Properties Limited
    Transactions
    • 08 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 janv. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture deed
    Créé le 08 nov. 2002
    Livré le 14 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 14 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0