AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED

AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAIGIS BLAST PROTECTION LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04083550
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    AIGIS ENGINEERING SOLUTIONS LIMITED04 oct. 200004 oct. 2000

    Quels sont les derniers comptes de AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 09 déc. 2014

    11 pages2.35B

    Changement d'adresse du siège social de 10 Furnival Street London EC4A 1AB à 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 01 août 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    15 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    15 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    29 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Unit 1 Bemrose Park Wayzgoose Drive Derby Derbyshire DE21 6st le 31 déc. 2013

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2013

    État du capital au 04 nov. 2013

    • Capital: GBP 11,467.42
    SH01

    Divers

    Auditors res.
    1 pagesMISC

    Deuxième dépôt de TM01 précédemment soumis à Companies House

    4 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    08 juil. 2013Second filing TM01 for Paul Doleman.

    Cessation de la nomination de Paul Andrew Doleman en tant que directeur le 02 juil. 2013

    2 pagesTM01
    Annotations
    DateAnnotation
    08 juil. 2013A second filing TM01 was registered on 08/07/13.

    Cessation de la nomination de Julian Paul Hare en tant que secrétaire le 28 nov. 2012

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Andrew Doleman le 04 avr. 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicolas Rogerson le 04 avr. 2011

    2 pagesCH01

    accounts-with-accounts-type-

    8 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 9 Davy Court Central Park Castle Mound Way Rugby Warwickshire CV23 0UZ le 18 oct. 2010

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    10 pagesAR01

    accounts-with-accounts-type-

    7 pagesAA

    legacy

    7 pagesMG01

    Nomination de Mr Paul Andrew Doleman en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DOUGHTY, Stuart John
    Bradley Farm House
    Kinlet
    DY12 3BU Bewdley
    Worcestershire
    Administrateur
    Bradley Farm House
    Kinlet
    DY12 3BU Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritishCivil Engineer31394540001
    ENGLISH, Peter David
    Coombe Lane West
    KT2 7BX Kingston Upon Thames
    10
    Surrey
    Administrateur
    Coombe Lane West
    KT2 7BX Kingston Upon Thames
    10
    Surrey
    EnglandBritishInvestor Director3355360003
    ROGERSON, Nicolas
    Bramham Gardens
    SW5 0HQ London
    45a
    United Kingdom
    Administrateur
    Bramham Gardens
    SW5 0HQ London
    45a
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector14482390004
    CHRISTIAN, David John
    44 Gisborne Crescent
    Allestree
    DE22 2FL Derby
    Secrétaire
    44 Gisborne Crescent
    Allestree
    DE22 2FL Derby
    BritishEngineer41355570002
    HARE, Julian Paul
    89 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DJ Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    89 Wychwood Avenue
    Knowle
    B93 9DJ Solihull
    West Midlands
    BritishAccountant2419760001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900014000001
    CHRISTIAN, David John
    44 Gisborne Crescent
    Allestree
    DE22 2FL Derby
    Administrateur
    44 Gisborne Crescent
    Allestree
    DE22 2FL Derby
    EnglandBritishEngineer41355570002
    COONEY, Eamonn Anthony
    31 The Lintons
    Sandon
    CM2 7UA Chelmsford
    Essex
    Administrateur
    31 The Lintons
    Sandon
    CM2 7UA Chelmsford
    Essex
    IrishDirector73027590001
    DOLEMAN, Paul Andrew
    Broadway
    Duffield
    DE56 4BU Belper
    52
    Derbyshire
    England
    Administrateur
    Broadway
    Duffield
    DE56 4BU Belper
    52
    Derbyshire
    England
    EnglandBritishCompany Director100901210002
    HOLLAND, Steven John, Mr.
    93 Longmoor Road
    NG10 4EG Long Eaton
    Derbyshire
    Administrateur
    93 Longmoor Road
    NG10 4EG Long Eaton
    Derbyshire
    EnglandBritishEngineer73417160001
    LAWRENCE, David Kenneth Anthony
    The Old Post House
    The Square
    NN11 3SH Moreton Pinkey
    Northamptonshire
    Administrateur
    The Old Post House
    The Square
    NN11 3SH Moreton Pinkey
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director34899950002
    LEDGER, Christopher John Walton
    21 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    Administrateur
    21 Langdon Park
    TW11 9PR Teddington
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director94249060001
    NAYLER, Robert William
    92 Hill Crescent
    DA5 2DB Bexley
    Kent
    Administrateur
    92 Hill Crescent
    DA5 2DB Bexley
    Kent
    United KingdomBritishDirector56435520001
    OTTOLLINI, Marco
    44 Church Lane
    CB8 9DJ Cheveley
    Suffolk
    Administrateur
    44 Church Lane
    CB8 9DJ Cheveley
    Suffolk
    DutchC E O116914840002
    SAUNDERS, Patrick James
    Portledge 29 Tylers Hill Road
    HP5 1XH Chesham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Portledge 29 Tylers Hill Road
    HP5 1XH Chesham
    Buckinghamshire
    BritishConsultant73417000001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Lancashire
    900013990001

    AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 22 juil. 2010
    Livré le 29 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Foresight 4 Vct PLC
    Transactions
    • 29 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 2008
    Livré le 17 déc. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other investors under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Foresight 4 Vct PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 17 déc. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 avr. 2003
    Livré le 29 avr. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage debenture
    Créé le 12 déc. 2001
    Livré le 19 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AIGIS BLAST PROTECTION LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    12 déc. 2013Administration started
    09 déc. 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Philip James Watkins
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    practitioner
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0