HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED

HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARRIS BROTHERS TYRES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04094497
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Micheldever Station Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HARRIS BROTHERS LIMITED23 oct. 200023 oct. 2000

    Quels sont les derniers comptes de HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Nomination de Mr Duncan Stewart Wilkes en tant qu'administrateur le 02 déc. 2013

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 nov. 2013

    État du capital au 19 nov. 2013

    • Capital: GBP 100
    SH01

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Richard Murray Sawney en tant que directeur le 28 sept. 2012

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2012

    13 pagesAA

    Nomination de Mr Jonathan Robert Cowles en tant que secrétaire le 05 juil. 2012

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Richard Murray Sawney en tant que secrétaire le 05 juil. 2012

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    16 pagesAA

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Senior facilities agreement 04/10/2011
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    legacy

    25 pagesMG01

    legacy

    21 pagesMG01

    Cessation de la nomination de Leighton Walker en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Leighton Walker en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Leighton Walker en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Derrick Phillipart en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Leighton Walker en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Jonathon Robert Cowles en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    170403550001
    COWLES, Jonathan Robert
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish122658610001
    WILKES, Duncan Stewart
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    Administrateur
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    EnglandBritish75861610001
    SAWNEY, Richard Murray
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    158217950001
    WALKER, Leighton
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    British72493980001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    PHILLIPART, Derrick Ivor
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish72493970002
    SAWNEY, Richard Murray
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish64848360001
    WALKER, Leighton
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Micheldever Station
    Micheldever Station
    SO21 3AP Winchester
    Micheldever Station
    Hampshire
    England
    United KingdomBritish72493980001

    HARRIS BROTHERS TYRES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Group debenture
    Créé le 05 oct. 2011
    Livré le 14 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present and future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited (Security Agent)
    Transactions
    • 14 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Group debenture
    Créé le 05 oct. 2011
    Livré le 14 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 14 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 08 janv. 2008
    Livré le 12 janv. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    112 ystrad road fforestfach swansea. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 04 juin 2004
    Livré le 18 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Tyre and exhaust depot, ellis avenue, haverfordwest. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 19 févr. 2002
    Livré le 27 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0