FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04096014
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    West Point 501 Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ENTERPRISE MAINTENANCE SERVICES LIMITED29 nov. 200129 nov. 2001
    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED25 oct. 200025 oct. 2000

    Quels sont les derniers comptes de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2013
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2014
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    8 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 sept. 2015

    9 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ England à West Point 501 Chester Rd Old Trafford Manchester M16 9HU le 12 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 04 sept. 2014

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de * Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX* le 29 mai 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 oct. 2013

    État du capital au 23 oct. 2013

    • Capital: GBP 1,358,129
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 28 déc. 2012

    9 pagesAA

    Cessation de la nomination de John Flood en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Nomination de Sherard Secretariat Services Limited en tant que secrétaire

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Paul Birch en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Andrew Latham Nelson en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Melvyn Ewell en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Arnold en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Ian Ellis Fraser en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Llewelyn Arnold en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de * Gordon House Sceptre Way Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 6AW United Kingdom* le 31 oct. 2011

    1 pagesAD01

    Qui sont les dirigeants de FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Secrétaire
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    Administrateur
    Chester Rd
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    West Point 501
    United KingdomBritishCompany Secretary76116640002
    EWELL, Melvyn
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Administrateur
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    EnglandBritishCeo61515760002
    NELSON, Andrew Latham
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    Administrateur
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    England
    United KingdomBritishFinance Director36191090003
    BIRCH, Paul
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    British76116640002
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Secrétaire
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    BritishSolicitor36153790001
    O'MALLEY, Ann Marie
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Secrétaire
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    British38211680002
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Secrétaire
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    BritishDirector25364820002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ARNOLD, David Llewelyn
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director181213200001
    BIRCH, Iain Harvey
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    Administrateur
    4 Eton Park
    PR2 9NL Preston
    Lancashire
    EnglandBritishCommercial Manager116126370001
    FLOOD, John Joseph
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManager73695830003
    FRASER, Ian Ellis
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Centurion Way
    PR26 6TX Leyland
    Lancaster House
    Lancashire
    United Kingdom
    ScotlandUkCeo28393850006
    GAVAN, John Vincent
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    23 Fulshaw Avenue
    SK9 5JE Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishSolicitor36153790001
    GREENBURY, Lee
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    Administrateur
    Sceptre Way
    Bamber Bridge
    PR5 6AW Preston
    Gordon House
    Lancashire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor61478920003
    KEOGH, Sean
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Whitehead Farm
    650 Whittingham Lane Goosnargh
    PR3 2JJ Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector123405900001
    KIRKBY, Neil Robert Ernest
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Dashwood Close
    Grappenhall
    WA4 3JA Warrington
    Cheshire
    EnglandBritishFinance Director51438040006
    MALONEY, John Gerard
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    Administrateur
    10 Pendle Hill
    Grimsargh
    PR2 5BG Preston
    Lancashire
    IrishChief Operating Officer96964980001
    MCGRORY, Jack
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    12 Woodlands Park
    Scarcroft
    LS14 3JU Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer96596920001
    MCINNES, Randolf Graham
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Journeys End
    Werneth Low
    SK14 3AF Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant100684180001
    MCLAUGHLIN, Owen Gerard
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    Administrateur
    Greyfriars Hall
    Walker Lane Fulwood
    PR2 7AN Preston
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector17129800004
    O'MALLEY, Desmond Francis
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    261 Didsbury Road
    Heaton Mersey
    SK4 3JG Stockport
    Cheshire
    BritishDirector55097840001
    O'MALLEY, Eammon
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    Administrateur
    32 Brooks Drive
    WA15 8TR Hale Barns
    Cheshire
    BritishDirector25364820002
    THORNTON, James Stephen
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    Administrateur
    9 Hilly Croft
    Bromley Cross
    BL7 9HN Bolton
    Lancashire
    BritishDirector67569070001

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 18 mai 2007
    Livré le 31 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 31 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 and
    Créé le 07 févr. 2002
    Livré le 09 févr. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The f/h property being land and buildings on the north west side of queen street, farnworth, t/no GM86886.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 09 févr. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 (the "debenture deed of accession")
    Créé le 01 nov. 2001
    Livré le 02 nov. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys obligations and liabilities for the time due owing or incurred by the obligors (as defined therein) or any of them to any of the beneficiaries (as defined therein) including without limitation all moneys obligations and liabilities for the time being due owing or incurred by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents (as defined) and/or on any other account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee Forand on Behalf of the Beneficaries (As Each Termis Defined in the Debenture Deed of Accession)
    Transactions
    • 02 nov. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 mars 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 18 mai 2001
    Livré le 07 juin 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a loan agreement dated 18TH may 2001 and any other monies under the debenture
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Enterprise PLC
    Transactions
    • 07 juin 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FIRST CLAIMS RESPONSE (MANCHESTER) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 sept. 2014Commencement of winding up
    09 avr. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Beverley Ellice Budsworth
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester
    practitioner
    The Debt Advisor West Point 501 Chester Road
    Old Trafford
    M16 9HU Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0