BLSSP (PHC 20) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBLSSP (PHC 20) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 04104030
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BLSSP (PHC 20) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe BLSSP (PHC 20) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BLSSP (PHC 20) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour BLSSP (PHC 20) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Notification de British Land Superstores (Non-Securitised) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 nov. 2019

    2 pagesPSC02

    Cessation de Blssp Property Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 27 nov. 2019

    1 pagesPSC07

    Comptes annuels établis au 31 mars 2020

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 nov. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Michael Pinkstone le 07 août 2020

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Hursh Shah en tant que directeur le 03 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Watson en tant que directeur le 03 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de James Andrew Honeyman en tant que directeur le 03 mars 2020

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 11 mars 2020

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Philip Gallier en tant que directeur le 03 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David William Pilbeam en tant que directeur le 03 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Bruce Richardson en tant que directeur le 03 mars 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Gallier en tant qu'administrateur le 03 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Martyn Stephen Burke en tant que directeur le 03 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Dean Clegg en tant que directeur le 26 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David William Pilbeam le 26 nov. 2019

    2 pagesCH01

    Nomination de Mr David William Pilbeam en tant qu'administrateur le 26 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de BLSSP (PHC 20) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    COWEN, Geraint Jamie
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director141040000003
    PINKSTONE, James Michael
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishCorporate Finance Executive241498640002
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Secrétaire
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    British32809000002
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Other138446320001
    SCUDAMORE, Rebecca Jane
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Secrétaire
    40 Canbury Avenue
    KT2 6JP Kingston Upon Thames
    Surrey
    Other72249480003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAM, Shenol
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    Administrateur
    13 Beech Drive
    N2 9NX London
    BritishCompany Director2068480001
    ATKINSON, William Stephen
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Surveyor174566650001
    BAGULEY, Peter Jeffrey
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    Administrateur
    Westridge Farm
    Daggerridge Plain Cadeleigh
    EX16 8HU Tiverton
    Devon
    United KingdomBritishChartered Surveyor175617500001
    BELL, Lucinda Margaret
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    Administrateur
    6 Priory Gardens
    Chiswick
    W4 1TT London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050004
    BELL-BROWN, Philip
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director119073370001
    BIRCH, John Matthew
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director191027500001
    BOWDEN, Robert Edward
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    Administrateur
    The Chase
    Ongar Road
    CM15 0DG Kelvedon Hatch
    Essex
    United KingdomBritishChartered Surveyor152497530001
    BRAINE, Anthony
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    Administrateur
    21 Woodville Road
    Ealing
    W5 2SE London
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    BURKE, Martyn Stephen
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152531940004
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    Administrateur
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLEGG, Dean
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director189632520001
    COHEN, Carolina Alfred
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Administrateur
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    United KingdomBritishInvestment Executive248093020001
    FLEMING, Richard Alexander
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant125990210002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    Administrateur
    44 Kerris Way
    Lower Earley
    RG6 5UW Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FRANCIS, Luke Thomas
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant223122340001
    GALLIER, Philip
    Rutherford Heights
    Rodney Road
    SE17 1AS London
    805
    United Kingdom
    Administrateur
    Rutherford Heights
    Rodney Road
    SE17 1AS London
    805
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Reporting Manager265528310001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    HESTER, Stephen Alan Michael
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    Administrateur
    3 Ilchester Place
    W14 8AA London
    BritishChief Executive51688320001
    HONEYMAN, James Andrew
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor201179510001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    Administrateur
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEARMONT, Richard John
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    Administrateur
    Holborn
    EC1N 2HT London
    33
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director116126860008
    LEWIS, Bryan John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor58257940003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    MAUDSLEY, Charles Sheridan Alexander
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director58478890003
    METLISS, Cyril
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    Administrateur
    25 Foscote Road
    Hendon
    NW4 3SE London
    BritishChartered Accountant3079600001
    MOORE, Stephen Howard
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishCorporate Finance Executive185276290002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BLSSP (PHC 20) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    27 nov. 2019
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueUnlimited With Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2039750
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Blssp Property Holdings Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 avr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    BLSSP (PHC 20) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Borrower deed of charge
    Créé le 28 févr. 2006
    Livré le 09 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the borrower secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Please refer to form 395 for details of property charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee) on Trust for Itself and the Otherborrower Secured Parties
    Transactions
    • 09 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 avr. 2019Une partie de la propriété ou de l'entreprise a été libérée et ne fait plus partie de la charge (MR05)
    • 19 déc. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental borrower deed of charge and release
    Créé le 30 juin 2005
    Livré le 08 juil. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrower to the borrower secured parties and the chargee and all monies due or to become due from the charging companies to the borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage all rights title and interest in and to the crawley property. By way of fixed charge all fixtures its interest in all benefits in respect of the insurances the benefit of all licences consents and authorisations and all rights title interest and benefit in to and under all contracts agreements deeds and documents. Fixed security its right title and interest in all charged income and any guarantee of charged income. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as Secured Note Trustee on Trust for Itself, Theother Borrower Secured Parties and the Borrower
    Transactions
    • 08 juil. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A supplemental borrower deed of charge supplemental to the borrower deed of charge dated 20 june 2001
    Créé le 15 août 2003
    Livré le 28 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all of its interest in the charged additional mortgaged property. All its rights under the agreement and declaration of trust and deed of instruction and indemnity. All fixtures owned by it at the charged additional mortgaged property and its interest in any fixtures in its possession. Its interest in all benefits in respect of the insurances to the extent that they relate to the charged additional mortgaged property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as Secured Note Trustee
    Transactions
    • 28 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge between amongst others blssp (funding) PLC (the "borrower"), the original charging companies and capita irg trustees limited (the "secured note registrar")
    Créé le 20 juin 2001
    Livré le 06 juil. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All present and future obligations and liabilities of the borrower to the borrower secured parties under: (1) the secured note trust deed; (2) any property advisory agreement; (3) the property management agreement; (4) the borrower bank agreement; (5) the borrower cash management agreement; (6) the secured note registrar agreement; and (7) clause 5(e) of the note subscription agreement. All present and future obligations and liabilities of the charging companies to the borrower under clause 2.2 of the borrower deed of charge (all terms as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Capita Irg Trustees Limited in Its Capacity as the Trustee Pursuant to Thesecured Note Trust Deed (The "Secured Note Trustee") on Trust for Itself and the Other Borrowersecured Parties
    Transactions
    • 06 juil. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0